-
CHESHIRE GROUNDWORKS LIMITED - C/O Cg&Co Gregs Building, 1 Booth Street, Manchester, M2 4DU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06634380
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Cg&Co Gregs Building
- 1 Booth Street
- Manchester
- M2 4DU C/O Cg&Co Gregs Building, 1 Booth Street, Manchester, M2 4DU UK
Management
- Geschäftsführung
- BIRCH, John William
- Prokuristen
- KBS CORPORATE SERVICES LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 01.07.2008
- Alter der Firma 2008-07-01 15 Jahre
- SIC/NACE
- 42990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr John William Birch
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- JANCOURT LTD.
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-09-30
- Letzte Einreichung: 2017-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-07-01
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-08-11
- Letzte Einreichung: 2018-07-28
-
CHESHIRE GROUNDWORKS LIMITED Firmenbeschreibung
- CHESHIRE GROUNDWORKS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06634380. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 01.07.2008 registriert. CHESHIRE GROUNDWORKS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen JANCOURT LTD. ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "42990" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2017 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 01.07.2012.Die Firma kann schriftlich über C/o Cg&co Gregs Building erreicht werden.
Jetzt sichern CHESHIRE GROUNDWORKS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Cheshire Groundworks Limited - C/O Cg&Co Gregs Building, 1 Booth Street, Manchester, M2 4DU, Grossbritannien
- 2008-07-01
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CHESHIRE GROUNDWORKS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-miscellaneous (2020-07-16) - LIQ MISC
-
liquidation-voluntary-resignation-liquidator (2020-07-22) - LIQ06
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-03-17) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-03-01) - 600
-
resolution (2019-03-01) - RESOLUTIONS
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-02-05) - MR04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-01-25) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2019-03-01) - LIQ02
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-26) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-09-22) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-03-14) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-04-20) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-28) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-12) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-30) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-05-12) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-28) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-02-26) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-02) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-27) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-07-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-07-21) - AR01
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name (2011-03-04) - AP04
-
termination-secretary-company-with-name (2011-03-04) - TM02
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-07-08) - AR01
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2010-07-08) - CH04
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-07-08) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-04-07) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-05-12) - 288a
-
legacy (2009-06-05) - 288b
-
legacy (2009-06-06) - 88(2)
-
legacy (2009-08-19) - 363a
-
legacy (2009-06-25) - 225
-
certificate-change-of-name-company (2009-06-19) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2008
-
incorporation-company (2008-07-01) - NEWINC
-
legacy (2008-07-25) - 287
-
legacy (2008-07-17) - 288b
-
legacy (2008-07-17) - 288a