-
GWE BIOGAS LTD - Sandhill Garton Road, Kirkburn, Driffield, East Yorkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06600650
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Sandhill Garton Road
- Kirkburn
- Driffield
- East Yorkshire
- YO25 9DR Sandhill Garton Road, Kirkburn, Driffield, East Yorkshire, YO25 9DR UK
Management
- Geschäftsführung
- GIRKING, Mathew James
- MEGGINSON, Thomas Alan Taylor
- Prokuristen
- MEGGINSON, Thomas Alan Taylor
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.05.2008
- Alter der Firma 2008-05-22 16 Jahre
- SIC/NACE
- 35110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Gwe Biogas Holdings Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- GREEN WOLD ENERGY LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-03-31
- Letzte Einreichung: 2019-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-06-05
- Letzte Einreichung: 2019-05-22
-
GWE BIOGAS LTD Firmenbeschreibung
- GWE BIOGAS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06600650. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 22.05.2008 registriert. GWE BIOGAS LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen GREEN WOLD ENERGY LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "35110" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/10/2011 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Sandhill Garton Road erreicht werden.
Jetzt sichern GWE BIOGAS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Gwe Biogas Ltd - Sandhill Garton Road, Kirkburn, Driffield, East Yorkshire, Grossbritannien
- 2008-05-22
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu GWE BIOGAS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-03-12) - AA
-
court-order (2020-02-14) - OC
keyboard_arrow_right 2019
-
(2019-03-17) - ANNOTATION
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-03-15) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-03-06) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-02-12) - PSC07
-
resolution (2018-02-08) - RESOLUTIONS
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-02-12) - PSC02
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-02-12) - PSC04
-
capital-alter-shares-subdivision (2018-02-12) - SH02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-17) - AA
-
capital-name-of-class-of-shares (2018-02-12) - SH08
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2018-06-20) - AA01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-11-26) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-11-26) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-07-27) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-05-25) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-09) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-07-04) - MR01
-
termination-director-company-with-name (2014-06-11) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-11) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-04-23) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-04-11) - MR04
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-06-19) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
legacy (2012-08-08) - MG01
-
accounts-with-accounts-type-small (2012-07-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-small (2011-08-04) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-05-23) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-05-23) - CH01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-03-03) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-06-29) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-06-29) - CH01
-
legacy (2010-10-15) - MG01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-10-05) - AD01
keyboard_arrow_right 2009
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2009-10-14) - AA01
-
legacy (2009-08-03) - 287
-
legacy (2009-05-26) - 363a
-
certificate-change-of-name-company (2009-05-01) - CERTNM
-
legacy (2009-03-19) - 287
keyboard_arrow_right 2008
-
incorporation-company (2008-05-22) - NEWINC
-
legacy (2008-12-17) - 288a
-
legacy (2008-06-11) - 288b
-
legacy (2008-06-11) - 288a