-
RITCHIE LAMBOR LIMITED - 313 Dyke Road, Hove, East Sussex, BN3 6PE, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06600408
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 313 Dyke Road
- Hove
- East Sussex
- BN3 6PE
- England 313 Dyke Road, Hove, East Sussex, BN3 6PE, England UK
Management
- Geschäftsführung
- RITCHIE, Craig Robertson
- Prokuristen
- OAKLEY, Lisa Mary
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.05.2008
- Alter der Firma 2008-05-22 15 Jahre
- SIC/NACE
- 74909
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Craig Robertson Ritchie
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-01-31
- Letzte Einreichung: 2020-04-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-06-05
- Letzte Einreichung: 2021-05-22
-
RITCHIE LAMBOR LIMITED Firmenbeschreibung
- RITCHIE LAMBOR LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06600408. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 22.05.2008 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74909" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30.04.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 313 Dyke Road erreicht werden.
Jetzt sichern RITCHIE LAMBOR LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Ritchie Lambor Limited - 313 Dyke Road, Hove, East Sussex, BN3 6PE, Grossbritannien
- 2008-05-22
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu RITCHIE LAMBOR LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-02-03) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2021-04-20) - AP03
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-22) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-10-24) - AP01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-10-26) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-11-19) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-11-19) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-12-16) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-01-29) - AA
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-12-20) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-18) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-25) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-17) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-06-17) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-30) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-21) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-01-13) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-19) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-06-19) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-01-31) - CH01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-01-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-01-25) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-01-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-07-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-06-24) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-06-24) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-12-12) - AA
-
legacy (2009-06-08) - 363a
-
legacy (2009-06-06) - 287
-
legacy (2009-06-05) - 288c
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-12-05) - 225
-
memorandum-articles (2008-09-10) - MEM/ARTS
-
incorporation-company (2008-05-22) - NEWINC
-
resolution (2008-09-10) - RESOLUTIONS