-
MICRO ALARMS FIRE AND SECURITY LIMITED - 3 Derby Road, Doncaster, South Yorkshire, DN2 4PQ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06578915
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 3 Derby Road
- Doncaster
- South Yorkshire
- DN2 4PQ 3 Derby Road, Doncaster, South Yorkshire, DN2 4PQ UK
Management
- Geschäftsführung
- FOWLER, Dean Peter
- FOWLER, Peter
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 29.04.2008
- Alter der Firma 2008-04-29 16 Jahre
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Dean Peter Fowler
- Mr Peter Fowler
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- TAYEMM2 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-01-29
- Letzte Einreichung: 2023-04-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-09-16
- Letzte Einreichung: 2023-09-02
-
MICRO ALARMS FIRE AND SECURITY LIMITED Firmenbeschreibung
- MICRO ALARMS FIRE AND SECURITY LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06578915. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 29.04.2008 registriert. MICRO ALARMS FIRE AND SECURITY LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen TAYEMM2 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/10/2011 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 3 Derby Road erreicht werden.
Jetzt sichern MICRO ALARMS FIRE AND SECURITY LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Micro Alarms Fire And Security Limited - 3 Derby Road, Doncaster, South Yorkshire, DN2 4PQ, Grossbritannien
- 2008-04-29
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MICRO ALARMS FIRE AND SECURITY LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2024-01-30) - AA
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-01-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-09-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-09-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2021-12-21) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-09-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-10-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-09-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-09-12) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-09-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-01-15) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-09-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-01-16) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-17) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-11-20) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-02) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-21) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-07-03) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-02) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2014-06-02) - TM01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2014-05-30) - AA01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-05-30) - MR04
-
termination-director-company (2014-05-27) - TM01
-
termination-director-company-with-name (2014-05-27) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-05-14) - AP01
keyboard_arrow_right 2013
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2013-10-30) - DISS40
-
gazette-notice-compulsary (2013-10-29) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-05-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-05-16) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-03-11) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-06-10) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-01-21) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-03-16) - 225
-
legacy (2009-05-01) - 363a
-
legacy (2009-06-08) - 288c
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-11-19) - 288c
-
legacy (2008-11-19) - 288a
-
legacy (2008-09-03) - 395
-
legacy (2008-08-20) - 288a
-
legacy (2008-08-18) - 288b
-
legacy (2008-08-18) - 288a
-
legacy (2008-08-18) - 287
-
legacy (2008-08-15) - 88(2)
-
certificate-change-of-name-company (2008-08-12) - CERTNM
-
incorporation-company (2008-04-29) - NEWINC