-
ALLCARE COMMUNITY CARE SERVICES LIMITED - Lynton House 7-12 Tavistock Square, London, WC1H 9LT, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06572113
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Lynton House 7-12 Tavistock Square
- London
- WC1H 9LT Lynton House 7-12 Tavistock Square, London, WC1H 9LT UK
Management
- Geschäftsführung
- OAKDEN, Pauline Elizabeth Mary
- OAKDEN, Russell Frederick
- Prokuristen
- OAKDEN, Pauline Elizabeth Mary
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 21.04.2008
- Alter der Firma 2008-04-21 16 Jahre
- SIC/NACE
- 86900
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2015-03-31
- Letzte Einreichung: 2013-06-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-04-21
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2017-05-05
- Letzte Einreichung:
-
ALLCARE COMMUNITY CARE SERVICES LIMITED Firmenbeschreibung
- ALLCARE COMMUNITY CARE SERVICES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06572113. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 21.04.2008 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "86900" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30/06/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 21.04.2012.Die Firma kann schriftlich über Lynton House 7-12 Tavistock Square erreicht werden.
Jetzt sichern ALLCARE COMMUNITY CARE SERVICES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Allcare Community Care Services Limited - Lynton House 7-12 Tavistock Square, London, WC1H 9LT, Grossbritannien
- 2008-04-21
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ALLCARE COMMUNITY CARE SERVICES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-04-07) - AD01
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2021-01-27) - LIQ10
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-04-07) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-04-17) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-10-09) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-04-12) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-03-08) - LIQ03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-02-08) - AD01
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-04-04) - 4.68
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-08-22) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2016-04-13) - 4.68
keyboard_arrow_right 2015
-
liquidation-in-administration-progress-report-with-brought-down-date (2015-02-23) - 2.24B
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2015-02-23) - 600
-
liquidation-in-administration-move-to-creditors-voluntary-liquidation (2015-02-02) - 2.34B
keyboard_arrow_right 2014
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2014-08-15) - 2.12B
-
liquidation-in-administration-statement-of-affairs-with-form-attached (2014-11-27) - 2.16B
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-09-17) - AD01
-
liquidation-in-administration-proposals (2014-08-20) - 2.17B
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-22) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-31) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-02) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-03-26) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-10-13) - AA
-
capital-allotment-shares (2011-10-13) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-07-14) - AR01
-
legacy (2011-06-10) - MG01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-03-31) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-02-18) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-04-21) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-10-15) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2010-10-15) - TM01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-05-01) - 363a
-
legacy (2009-03-17) - 395
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-08-22) - 225
-
legacy (2008-07-11) - 395
-
incorporation-company (2008-04-21) - NEWINC