-
ECO2 GREETINGS LIMITED - Building 1 Olympic Way, Birchwood, Warrington, WA2 0YL, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06539564
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Building 1 Olympic Way
- Birchwood
- Warrington
- WA2 0YL
- England Building 1 Olympic Way, Birchwood, Warrington, WA2 0YL, England UK
Management
- Geschäftsführung
- HATTON, Benjamin
- WOOLFORD, Alec James
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 19.03.2008
- Alter der Firma 2008-03-19 16 Jahre
- SIC/NACE
- 63990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Ilium Retail Ltd
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-12-31
- Letzte Einreichung: 2021-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2014-03-19
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-03-15
- Letzte Einreichung: 2021-03-01
-
ECO2 GREETINGS LIMITED Firmenbeschreibung
- ECO2 GREETINGS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06539564. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 19.03.2008 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "63990" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 19.03.2014.Die Firma kann schriftlich über Building 1 Olympic Way erreicht werden.
Jetzt sichern ECO2 GREETINGS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Eco2 Greetings Limited - Building 1 Olympic Way, Birchwood, Warrington, WA2 0YL, Grossbritannien
- 2008-03-19
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ECO2 GREETINGS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-03-31) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-30) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-03-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-12-03) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-12-03) - PSC02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-12-03) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-12-03) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-12-03) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-14) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-30) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-09-20) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-06-07) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-22) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-08-17) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-08-17) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-11) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-08-17) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-22) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-09) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-15) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-03-03) - AP01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-07-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-04-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-12-28) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-12-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-03-25) - AR01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2010-03-24) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-03-24) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-01-18) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-03-23) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
incorporation-company (2008-03-19) - NEWINC
-
legacy (2008-05-15) - 88(2)