-
TOYS DIRECT LIMITED - Bede House, 3 Belmont Business Park, Durham, DH1 1TW, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06525292
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Bede House
- 3 Belmont Business Park
- Durham
- DH1 1TW Bede House, 3 Belmont Business Park, Durham, DH1 1TW UK
Management
- Geschäftsführung
- CUTHBERT, Vanessa
- PARRISH, Brian James
- PARRISH, James Gordon
- PARRISH, Linda Jean
- Prokuristen
- PARRISH, Linda Jean
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 05.03.2008
- Gelöscht am:
- 2020-08-26
- SIC/NACE
- 47910
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- ENDEAVOUR 111 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2015-09-30
- Letzte Einreichung: 2013-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-03-05
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2017-03-19
- Letzte Einreichung:
-
TOYS DIRECT LIMITED Firmenbeschreibung
- TOYS DIRECT LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06525292. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 05.03.2008 registriert. TOYS DIRECT LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen ENDEAVOUR 111 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47910" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2013 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 05.03.2012.Die Firma kann schriftlich über Bede House erreicht werden.
Jetzt sichern TOYS DIRECT LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Toys Direct Limited - Bede House, 3 Belmont Business Park, Durham, DH1 1TW, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu TOYS DIRECT LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-08-26) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2020-05-26) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-05-14) - LIQ03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-10-09) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-06-13) - LIQ03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-02-08) - AD01
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2017-07-20) - 600
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2017-07-20) - LIQ10
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-06-03) - 4.68
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2016-06-22) - 4.68
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-08-15) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2015-04-20) - 4.20
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2015-04-20) - 600
-
resolution (2015-04-20) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-03-27) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-03) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-02-25) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
legacy (2012-11-26) - MG04
-
legacy (2012-11-26) - MG02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-10-05) - AD01
-
resolution (2012-03-29) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2012-03-27) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-03-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2011-10-17) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-03-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-07-09) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-08-04) - AA
-
legacy (2009-07-24) - 287
-
legacy (2009-03-28) - 363a
-
legacy (2009-03-25) - 395
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-07-01) - 395
-
incorporation-company (2008-03-05) - NEWINC
-
certificate-change-of-name-company (2008-05-07) - CERTNM