-
S & R DECOR LIMITED - 15 Borough Road, Dunstable, LU5 4BZ, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06524510
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 15 Borough Road
- Dunstable
- LU5 4BZ
- England 15 Borough Road, Dunstable, LU5 4BZ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- WHEELDON, Russell Joseph
- WHEELDON, Scott Paul
- Prokuristen
- WHEELDON, Lynsey
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 05.03.2008
- Alter der Firma 2008-03-05 16 Jahre
- SIC/NACE
- 43341
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Russell Joseph Wheeldon
- Mr Scott Paul Wheeldon
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-12-31
- Letzte Einreichung: 2022-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-04-18
- Letzte Einreichung: 2023-04-04
-
S & R DECOR LIMITED Firmenbeschreibung
- S & R DECOR LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06524510. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 05.03.2008 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43341" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 15 Borough Road erreicht werden.
Jetzt sichern S & R DECOR LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: S & R Decor Limited - 15 Borough Road, Dunstable, LU5 4BZ, England, Grossbritannien
- 2008-03-05
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu S & R DECOR LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-04-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-04-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2022-07-19) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2021-07-16) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-04-09) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-06-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-04-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-08-01) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-07-19) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-03-22) - AD01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-03-22) - TM02
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-29) - CS01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-03-22) - AP03
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2017-12-21) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-25) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-30) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-22) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-19) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2013-04-08) - CH03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-03-26) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-23) - AA
-
capital-name-of-class-of-shares (2013-07-23) - SH08
keyboard_arrow_right 2012
-
capital-allotment-shares (2012-08-22) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-08-28) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2012-08-22) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name (2012-08-22) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-30) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-04-30) - CH01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-07) - AR01
-
termination-secretary-company-with-name (2011-05-12) - TM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-07-21) - AD01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-07-21) - AP03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-07-26) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-06-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-03-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-10-29) - AA
-
legacy (2009-03-05) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
incorporation-company (2008-03-05) - NEWINC
-
legacy (2008-05-19) - 288c