-
LVH SERVICES LTD. - 142-148 Main Road, Sidcup, Kent, DA14 6NZ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06513321
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 142-148 Main Road
- Sidcup
- Kent
- DA14 6NZ 142-148 Main Road, Sidcup, Kent, DA14 6NZ UK
Management
- Geschäftsführung
- HEARD, Steven Ronald
- Prokuristen
- NATIONWIDE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 26.02.2008
- Alter der Firma 2008-02-26 16 Jahre
- SIC/NACE
- 52290
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- L V ASSETS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2012-11-30
- Letzte Einreichung: 2011-02-28
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2011-02-26
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2017-03-12
- Letzte Einreichung:
-
LVH SERVICES LTD. Firmenbeschreibung
- LVH SERVICES LTD. ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06513321. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 26.02.2008 registriert. LVH SERVICES LTD. hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen L V ASSETS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "52290" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 28/02/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 26.02.2011.Die Firma kann schriftlich über 142-148 Main Road erreicht werden.
Jetzt sichern LVH SERVICES LTD. HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Lvh Services Ltd. - 142-148 Main Road, Sidcup, Kent, DA14 6NZ, Grossbritannien
- 2008-02-26
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LVH SERVICES LTD. aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2021-03-24) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-04-21) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-04-27) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-04-09) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-04-11) - 4.68
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2016-04-22) - 4.68
keyboard_arrow_right 2015
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2015-05-08) - 4.68
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-02-18) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2014-02-17) - 4.20
-
resolution (2014-02-17) - RESOLUTIONS
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2014-02-13) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsary (2014-01-28) - GAZ1
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2014-02-17) - 600
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-22) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-10-30) - AP01
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2013-10-23) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsary (2013-10-15) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2013-07-23) - DISS40
-
termination-director-company-with-name (2013-07-19) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2013-06-05) - MR04
keyboard_arrow_right 2012
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2012-07-24) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsary (2012-06-26) - GAZ1
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-04-30) - CH01
-
legacy (2012-03-07) - MG01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-12-01) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-03-05) - AR01
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2010-03-05) - CH04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-11-05) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2009-11-27) - AA
-
legacy (2009-09-19) - 395
-
certificate-change-of-name-company (2009-09-05) - CERTNM
-
legacy (2009-04-06) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-02-29) - 288a
-
legacy (2008-02-29) - 288b
-
incorporation-company (2008-02-26) - NEWINC