-
CREAM DIRECTORS LIMITED - The Cottage, Bodsham, Ashford, Kent, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06511719
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Cottage
- Bodsham
- Ashford
- Kent
- TN25 5JQ
- England The Cottage, Bodsham, Ashford, Kent, TN25 5JQ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- DICKSON, Gary
- WOOD, Peggy Joyce
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 21.02.2008
- Alter der Firma 2008-02-21 16 Jahre
- SIC/NACE
- 93290
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Gary Dickson
- Ms Peggy Joyce Wood
- Mr Gary Dickson
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- YAZOO SCRIPTS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-07-31
- Letzte Einreichung: 2022-10-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-02-21
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-01-24
- Letzte Einreichung: 2023-01-10
-
CREAM DIRECTORS LIMITED Firmenbeschreibung
- CREAM DIRECTORS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06511719. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 21.02.2008 registriert. CREAM DIRECTORS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen YAZOO SCRIPTS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "93290" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.10.2022 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 21.02.2012.Die Firma kann schriftlich über The Cottage erreicht werden.
Jetzt sichern CREAM DIRECTORS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Cream Directors Limited - The Cottage, Bodsham, Ashford, Kent, Grossbritannien
- 2008-02-21
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CREAM DIRECTORS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-01-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-07-30) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-03-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-07-18) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-01-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-07-29) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-27) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-31) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-01-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-07-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-25) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-02-25) - CH01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-07-30) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-31) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-15) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-11) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-02-26) - CH01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2015-01-17) - DISS40
keyboard_arrow_right 2014
-
gazette-notice-compulsory (2014-10-28) - GAZ1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-27) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-25) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-07-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2011-04-12) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-10-07) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2010-12-10) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-07-15) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-07-15) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-07-09) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-05-19) - AA
-
termination-secretary-company-with-name (2010-03-30) - TM02
keyboard_arrow_right 2009
-
certificate-change-of-name-company (2009-11-18) - CERTNM
-
resolution (2009-11-18) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name (2009-11-05) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2009-11-05) - TM01
-
legacy (2009-03-03) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-04-24) - 225
-
incorporation-company (2008-02-21) - NEWINC