-
CELTIC MACHINES LTD - Unit 68, Vale Business Park, Llandow, Cowbridge, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06500700
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 68
- Vale Business Park
- Llandow
- Cowbridge
- CF71 7PF
- Wales Unit 68, Vale Business Park, Llandow, Cowbridge, CF71 7PF, Wales UK
Management
- Geschäftsführung
- THOMAS, Gareth John
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 12.02.2008
- Gelöscht am:
- 2016-12-20
- SIC/NACE
- 25990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Gareth John Thomas
- -
- Metal Innovations Holdings Plc
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- CYMRU COAL LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-04-30
- Letzte Einreichung: 2019-04-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-02-12
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-03-26
- Letzte Einreichung: 2020-02-12
-
CELTIC MACHINES LTD Firmenbeschreibung
- CELTIC MACHINES LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06500700. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 12.02.2008 registriert. CELTIC MACHINES LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen CYMRU COAL LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "25990" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.10.2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 12.02.2013.Die Firma kann schriftlich über Unit 68 erreicht werden.
Jetzt sichern CELTIC MACHINES LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Celtic Machines Ltd - Unit 68, Vale Business Park, Llandow, Cowbridge, Grossbritannien
- 2008-02-12
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CELTIC MACHINES LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-01-05) - AD01
keyboard_arrow_right 2020
-
resolution (2020-09-09) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-08-14) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-12) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-02-11) - MR04
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-02-07) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-01-28) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-08-14) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-08-21) - PSC03
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-11-20) - PSC02
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-04-29) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-10-31) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2018-03-26) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-02-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-07-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-31) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-01-27) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-01-08) - AA
-
administrative-restoration-company (2017-01-08) - RT01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-30) - AR01
-
gazette-dissolved-compulsory (2016-12-20) - GAZ2
-
gazette-notice-compulsory (2016-10-04) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-05-12) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-09) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-01-05) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-03-09) - TM02
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-11-20) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-05-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-full (2013-05-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-03-08) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-full (2012-04-26) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-03-30) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-full (2011-11-01) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-02-15) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2011-01-24) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
legacy (2010-08-19) - MG01
-
termination-secretary-company-with-name (2010-07-27) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-05-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-05-22) - 225
-
legacy (2009-05-18) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-full (2009-08-02) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2009-11-19) - AD01
keyboard_arrow_right 2008
-
incorporation-company (2008-02-12) - NEWINC