-
MACLINCORRY LIMITED - 1066 London Road, Leigh On Sea, Essex, SS9 3NA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06473134
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1066 London Road
- Leigh On Sea
- Essex
- SS9 3NA 1066 London Road, Leigh On Sea, Essex, SS9 3NA UK
Management
- Geschäftsführung
- MCLINTOCK, Andrew Cadzow
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.01.2008
- Alter der Firma 2008-01-15 16 Jahre
- SIC/NACE
- 43330
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2015-09-30
- Letzte Einreichung: 2013-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-17
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2017-01-31
- Letzte Einreichung:
-
MACLINCORRY LIMITED Firmenbeschreibung
- MACLINCORRY LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06473134. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 15.01.2008 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43330" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2013 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 17.01.2013.Die Firma kann schriftlich über 1066 London Road erreicht werden.
Jetzt sichern MACLINCORRY LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Maclincorry Limited - 1066 London Road, Leigh On Sea, Essex, SS9 3NA, Grossbritannien
- 2008-01-15
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MACLINCORRY LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2023-07-21) - LIQ03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-07-31) - AD01
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2023-08-18) - LIQ10
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2023-08-18) - 600
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2022-06-08) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2022-11-02) - LIQ10
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2022-11-02) - 600
keyboard_arrow_right 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-06-02) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-07-02) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-07-25) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-06-06) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-07-12) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2016-07-12) - 4.68
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-06-03) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2015-06-02) - 4.20
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2015-06-02) - 600
-
resolution (2015-06-02) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
termination-secretary-company-with-name (2012-04-26) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-28) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-04-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-26) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-04-26) - CH01
keyboard_arrow_right 2011
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-11-18) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-01-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-09-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-01-18) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-01-18) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-09-03) - AA
-
legacy (2009-01-19) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
incorporation-company (2008-01-15) - NEWINC
-
legacy (2008-01-17) - 225