-
COUNTRYSIDE PRODUCTS (LIVERPOOL) LIMITED - C/O FRP ADVISORY LLP, 4th Floor Abbey House 32 Booth Street, Manchester, M2 4AB, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06469295
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O FRP ADVISORY LLP
- 4th Floor Abbey House 32 Booth Street
- Manchester
- M2 4AB C/O FRP ADVISORY LLP, 4th Floor Abbey House 32 Booth Street, Manchester, M2 4AB UK
Management
- Geschäftsführung
- CAPLAN, Geraldine Preston
- CAPLAN, Maurice Frank Robert
- Prokuristen
- CAPLAN, Geraldine Preston
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 10.01.2008
- Gelöscht am:
- 2020-02-11
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Geraldine Preston Caplan
- Mr Maurice Frank Robert Caplan
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2014-09-30
- Letzte Einreichung: 2017-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-10
-
COUNTRYSIDE PRODUCTS (LIVERPOOL) LIMITED Firmenbeschreibung
- COUNTRYSIDE PRODUCTS (LIVERPOOL) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06469295. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 10.01.2008 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2017 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 10.01.2013.Die Firma kann schriftlich über C/o Frp Advisory Llp erreicht werden.
Jetzt sichern COUNTRYSIDE PRODUCTS (LIVERPOOL) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Countryside Products (Liverpool) Limited - C/O FRP ADVISORY LLP, 4th Floor Abbey House 32 Booth Street, Manchester, M2 4AB, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu COUNTRYSIDE PRODUCTS (LIVERPOOL) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-02-11) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-in-administration-proposals (2019-01-16) - AM03
-
liquidation-in-administration-statement-of-affairs-with-form-attached (2019-01-18) - AM02
-
liquidation-in-administration-move-to-dissolution (2019-11-11) - AM23
-
liquidation-in-administration-progress-report (2019-06-28) - AM10
-
liquidation-administration-notice-deemed-approval-of-proposals (2019-01-24) - AM06
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-12-06) - AD01
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2018-12-05) - AM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-25) - CS01
-
resolution (2017-01-11) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-08-11) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-11-13) - MR04
-
capital-allotment-shares (2017-04-24) - SH01
keyboard_arrow_right 2016
-
resolution (2016-12-21) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-08-23) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-12) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-09-16) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-12) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-04-18) - AP01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2013-02-26) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-02-26) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-20) - AR01
-
legacy (2013-01-15) - MG01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-04-29) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-04-18) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-01-31) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-06-07) - AA
-
accounts-amended-with-made-up-date (2011-06-07) - AAMD
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-01-31) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-02-03) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-03-01) - AA
-
capital-allotment-shares (2010-05-07) - SH01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-02-24) - AA
-
legacy (2009-02-02) - 363a
-
legacy (2009-01-19) - 288b
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-07-23) - 225
-
legacy (2008-02-23) - 395
-
legacy (2008-01-28) - 288a
-
legacy (2008-01-22) - 288a
-
incorporation-company (2008-01-10) - NEWINC