-
ONE DIGITAL SOLUTIONS LTD - Dmc Recovery Limited 41, Greek Street, Stockport, Cheshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06457209
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Dmc Recovery Limited 41
- Greek Street
- Stockport
- Cheshire
- SK3 8AX Dmc Recovery Limited 41, Greek Street, Stockport, Cheshire, SK3 8AX UK
Management
- Geschäftsführung
- WESTHEAD, Richard Paul
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 19.12.2007
- Gelöscht am:
- 2021-09-29
- SIC/NACE
- 73120
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Richard Paul Westhead
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- CHAMBER TV LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2018-09-30
- Letzte Einreichung: 2016-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-19
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2018-12-29
- Letzte Einreichung: 2017-12-15
-
ONE DIGITAL SOLUTIONS LTD Firmenbeschreibung
- ONE DIGITAL SOLUTIONS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06457209. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 19.12.2007 registriert. ONE DIGITAL SOLUTIONS LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen CHAMBER TV LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "73120" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2016 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 19.12.2012.Die Firma kann schriftlich über Dmc Recovery Limited 41 erreicht werden.
Jetzt sichern ONE DIGITAL SOLUTIONS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: One Digital Solutions Ltd - Dmc Recovery Limited 41, Greek Street, Stockport, Cheshire, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ONE DIGITAL SOLUTIONS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-05-25) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
resolution (2018-03-22) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2018-03-22) - 600
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-03-28) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2018-03-22) - LIQ02
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-23) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-12-23) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-09-27) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-06) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-10-06) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-07-08) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-07-04) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-01-06) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-06) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-06-01) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-07-07) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-21) - AA
-
capital-allotment-shares (2015-08-19) - SH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-12-15) - CH01
-
resolution (2015-08-19) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-02) - AR01
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-30) - AAMD
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-17) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-08-23) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-04-22) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-04-04) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-15) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-01-15) - AP01
keyboard_arrow_right 2012
-
certificate-change-of-name-company (2012-12-11) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2012-12-11) - CONNOT
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-03-13) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-01-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-09-28) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-08-01) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-01-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-01-19) - CH01
-
termination-secretary-company-with-name (2010-01-19) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-01-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-10-04) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-01-19) - AD01
keyboard_arrow_right 2009
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2009-12-10) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2009-04-20) - AA
-
legacy (2009-02-04) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-02-02) - 288a
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-12-28) - 288b
-
incorporation-company (2007-12-19) - NEWINC