-
BODY POWER PTS LIMITED - Lifford Hall Lifford Lane, Kings Norton, Birmingham, West Midlands, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06445555
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Lifford Hall Lifford Lane
- Kings Norton
- Birmingham
- West Midlands
- B30 3JN Lifford Hall Lifford Lane, Kings Norton, Birmingham, West Midlands, B30 3JN UK
Management
- Geschäftsführung
- ORTON, Nicholas Simon Piers
- ORTON, Steven James Grahame
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 05.12.2007
- Gelöscht am:
- 2020-11-17
- SIC/NACE
- 82301
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Pioneer Shows Holdings Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- PIONEER SHOWS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit:
- Letzte Einreichung: 2017-05-31
-
BODY POWER PTS LIMITED Firmenbeschreibung
- BODY POWER PTS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06445555. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 05.12.2007 registriert. BODY POWER PTS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen PIONEER SHOWS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82301" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.05.2017 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Lifford Hall Lifford Lane erreicht werden.
Jetzt sichern BODY POWER PTS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Body Power Pts Limited - Lifford Hall Lifford Lane, Kings Norton, Birmingham, West Midlands, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BODY POWER PTS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-compulsory (2020-11-17) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-01-21) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2019-02-20) - AA01
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2019-12-07) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2019-11-05) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2018
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-07-31) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-02-27) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-09-11) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-09-11) - TM02
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-12-08) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-13) - AA
-
change-person-director-company (2017-12-11) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-12-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-09) - CS01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-06) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-01) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-02-06) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-01-06) - CH01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-11) - AR01
-
certificate-change-of-name-company (2014-10-29) - CERTNM
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-01-22) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-16) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-23) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-10-10) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-03-04) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2012-09-10) - CH03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-02-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-01-11) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-09-10) - CH01
keyboard_arrow_right 2011
-
capital-allotment-shares (2011-10-18) - SH01
-
termination-director-company-with-name (2011-06-27) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-06-27) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-05-06) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2011-02-10) - CERTNM
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2011-01-25) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
gazette-notice-compulsary (2010-04-06) - GAZ1
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-06-14) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-06-14) - CH01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2010-06-19) - DISS40
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2010-10-01) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-12-22) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-06-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2009-09-30) - AA
-
legacy (2009-03-17) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-02-26) - 288c
-
legacy (2008-02-15) - 288a
-
legacy (2008-02-15) - 288b
keyboard_arrow_right 2007
-
incorporation-company (2007-12-05) - NEWINC