-
WENTWORTH JAMES LTD - C/O Minel, Cathedral Buildings, Dean Street, Newcastle Upon Tyne, NE1 1PG, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06434786
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Minel, Cathedral Buildings
- Dean Street
- Newcastle Upon Tyne
- NE1 1PG
- England C/O Minel, Cathedral Buildings, Dean Street, Newcastle Upon Tyne, NE1 1PG, England UK
Management
- Geschäftsführung
- WADE, John
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.11.2007
- Alter der Firma 2007-11-22 16 Jahre
- SIC/NACE
- 64921
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Timothy John Whiting
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-07-20
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-04-12
- Letzte Einreichung: 2020-03-01
-
WENTWORTH JAMES LTD Firmenbeschreibung
- WENTWORTH JAMES LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06434786. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 22.11.2007 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64921" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.11.2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 20.07.2012.Die Firma kann schriftlich über C/o Minel, Cathedral Buildings erreicht werden.
Jetzt sichern WENTWORTH JAMES LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Wentworth James Ltd - C/O Minel, Cathedral Buildings, Dean Street, Newcastle Upon Tyne, NE1 1PG, Grossbritannien
- 2007-11-22
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu WENTWORTH JAMES LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-01-01) - PSC04
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-03-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-12-30) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2018-10-03) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-08-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-03) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-07-03) - PSC01
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-04-03) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-18) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-03-14) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-11-08) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-11-11) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2017-10-31) - GAZ1
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-04-03) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-22) - AR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-02-02) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-01) - AA
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2016-01-28) - DISS16(SOAS)
keyboard_arrow_right 2015
-
gazette-notice-compulsory (2015-12-01) - GAZ1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-11-14) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-18) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-05-08) - AD01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-08-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-27) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2013-08-27) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-08-27) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-08-27) - AD01
keyboard_arrow_right 2012
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-12-03) - AD01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2012-12-01) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-11-29) - AA
-
gazette-notice-compulsary (2012-11-27) - GAZ1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-08-31) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-08-31) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-08-24) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-full (2010-09-03) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-09-28) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-09-28) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-02-26) - 288b
-
legacy (2009-02-26) - 288a
-
legacy (2009-02-26) - 287
-
legacy (2009-04-20) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2009-09-11) - AA
-
legacy (2009-07-20) - 288a
-
legacy (2009-07-27) - 288b
-
legacy (2009-08-05) - 363a
-
legacy (2009-07-17) - 287
keyboard_arrow_right 2007
-
incorporation-company (2007-11-22) - NEWINC