-
ELY HOUSE GALLERY LIMITED - 399, Strand, London, WC2R 0LX, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06432794
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 399
- Strand
- London
- WC2R 0LX
- England 399, Strand, London, WC2R 0LX, England UK
Management
- Geschäftsführung
- GEE, Anthony Michael
- PURKIS, Richard Kenneth
- Prokuristen
- PURKIS, Richard Kenneth
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 21.11.2007
- Alter der Firma 2007-11-21 16 Jahre
- SIC/NACE
- 99999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Milsom Street Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- JAMES HARVEY BRITISH ART LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-01-02
- Letzte Einreichung: 2019-11-21
-
ELY HOUSE GALLERY LIMITED Firmenbeschreibung
- ELY HOUSE GALLERY LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06432794. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 21.11.2007 registriert. ELY HOUSE GALLERY LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen JAMES HARVEY BRITISH ART LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "99999" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/12/2011 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 399 erreicht werden.
Jetzt sichern ELY HOUSE GALLERY LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Ely House Gallery Limited - 399, Strand, London, WC2R 0LX, Grossbritannien
- 2007-11-21
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ELY HOUSE GALLERY LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2020-09-11) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2019-10-24) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-21) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-11-21) - PSC05
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-01-04) - AA
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-12-03) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-11-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-09-19) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-02-26) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-04-11) - AA
-
auditors-resignation-company (2016-04-29) - AUD
-
auditors-resignation-company (2016-05-03) - AUD
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-05-10) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
miscellaneous (2015-02-04) - MISC
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2015-03-13) - AA01
-
auditors-resignation-company (2015-04-24) - AUD
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-06-16) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-09-23) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-09-23) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-09-23) - AP03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-24) - AR01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-09-23) - TM02
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-03) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-12-01) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-09-22) - MR04
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-full (2013-09-18) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-16) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2013-12-16) - TM01
-
certificate-change-of-name-company (2013-09-09) - CERTNM
-
resolution (2013-07-08) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2012-06-14) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-03-01) - AD01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-12) - AR01
-
auditors-resignation-company (2011-11-03) - AUD
-
auditors-resignation-company (2011-10-25) - AUD
-
accounts-with-accounts-type-full (2011-09-12) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
legacy (2010-02-25) - MG01
-
capital-allotment-shares (2010-05-04) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-full (2010-09-02) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-12-08) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-12-08) - AR01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2010-12-08) - CH03
keyboard_arrow_right 2009
-
resolution (2009-06-10) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-full (2009-09-14) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-12-07) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-12-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-12-11) - 363a
-
legacy (2008-12-11) - 288c
-
legacy (2008-01-21) - 225
-
legacy (2008-01-21) - 287
-
legacy (2008-01-21) - 288b
-
legacy (2008-01-21) - 288a
-
memorandum-articles (2008-01-14) - MEM/ARTS
-
certificate-change-of-name-company (2008-01-10) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2007
-
incorporation-company (2007-11-21) - NEWINC