-
THE SURREY PARK CLINIC (IHG) LTD - Unit 2, Stirling House, Stirling Road, Guildford, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06405621
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 2
- Stirling House
- Stirling Road
- Guildford
- Surrey
- GU2 7RF Unit 2, Stirling House, Stirling Road, Guildford, Surrey, GU2 7RF UK
Management
- Geschäftsführung
- DIBDEN, Lindsay George
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.10.2007
- Alter der Firma 2007-10-22 16 Jahre
- SIC/NACE
- 86220
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Lindsay George Dibden
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-22
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-11-05
- Letzte Einreichung: 2020-10-22
-
THE SURREY PARK CLINIC (IHG) LTD Firmenbeschreibung
- THE SURREY PARK CLINIC (IHG) LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06405621. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 22.10.2007 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "86220" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.10.2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 22.10.2012.Die Firma kann schriftlich über Unit 2 erreicht werden.
Jetzt sichern THE SURREY PARK CLINIC (IHG) LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: The Surrey Park Clinic (Ihg) Ltd - Unit 2, Stirling House, Stirling Road, Guildford, Grossbritannien
- 2007-10-22
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu THE SURREY PARK CLINIC (IHG) LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-22) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-04-14) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-04) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-11-04) - PSC04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-07-10) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-19) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
resolution (2018-01-05) - RESOLUTIONS
-
capital-name-of-class-of-shares (2018-01-09) - SH08
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2018-01-09) - SH10
-
capital-alter-shares-subdivision (2018-01-09) - SH02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-22) - AP01
-
capital-allotment-shares (2018-01-09) - SH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-11-05) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-11-05) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-05) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2018-12-05) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-19) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-20) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-03-27) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-01-08) - AA01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-26) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-10-09) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-01) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-22) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-02-18) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-02-25) - AP01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-20) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2014-05-02) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-01-19) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2014-01-17) - AA01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-07-29) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-08-13) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2011-09-21) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2011-07-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-11-13) - AR01
-
termination-secretary-company-with-name (2010-11-13) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2010-08-05) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-05-24) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-05-19) - AD01
-
gazette-notice-compulsary (2010-03-02) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2009-08-02) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-11-18) - 288a
-
legacy (2008-11-18) - 288b
-
legacy (2008-11-18) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
incorporation-company (2007-10-22) - NEWINC