-
SMR DOVER LIMITED - Bank Chambers, 1 Central Avenue, Sittingbourne, Kent, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06403969
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Bank Chambers
- 1 Central Avenue
- Sittingbourne
- Kent
- ME10 4AE Bank Chambers, 1 Central Avenue, Sittingbourne, Kent, ME10 4AE UK
Management
- Geschäftsführung
- ROBINSON, Suzanne Marie
- Prokuristen
- ROBINSON, Suzanne Marie
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 19.10.2007
- Gelöscht am:
- 2021-03-03
- SIC/NACE
- 78200
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Suzanne Marie Robinson
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- CMS EMPLOYMENT AGENCY LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-10-31
- Letzte Einreichung: 2018-01-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-19
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-11-02
- Letzte Einreichung: 2018-10-19
-
SMR DOVER LIMITED Firmenbeschreibung
- SMR DOVER LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06403969. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 19.10.2007 registriert. SMR DOVER LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen CMS EMPLOYMENT AGENCY LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "78200" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/01/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 19.10.2012.Die Firma kann schriftlich über Bank Chambers erreicht werden.
Jetzt sichern SMR DOVER LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Smr Dover Limited - Bank Chambers, 1 Central Avenue, Sittingbourne, Kent, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SMR DOVER LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-voluntary-members-return-of-final-meeting (2020-12-03) - LIQ13
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-06-25) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2019-05-13) - LIQ01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-05-13) - 600
-
resolution (2019-05-13) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-05-14) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
resolution (2018-04-13) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-04-20) - AD01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-04-12) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-31) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-26) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-31) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-31) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-19) - AR01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2015-10-19) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-10-19) - CH01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-22) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-22) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-10-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-26) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2011-10-26) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-10-17) - AA
-
legacy (2011-07-16) - MG01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-10-20) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-10-28) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-10-22) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-08-03) - AA
-
legacy (2009-05-21) - 225
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-10-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-10-21) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
incorporation-company (2007-10-19) - NEWINC