-
FOYCOL LIMITED - Ashley House, 415 Halifax Road, Brighouse, Yorkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06384273
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Ashley House
- 415 Halifax Road
- Brighouse
- Yorkshire
- HD6 2PD Ashley House, 415 Halifax Road, Brighouse, Yorkshire, HD6 2PD UK
Management
- Geschäftsführung
- FOY, Andrew Charles
- FOY, Julie Ellen
- Prokuristen
- FOY, Andrew Charles
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 28.09.2007
- Alter der Firma 2007-09-28 16 Jahre
- SIC/NACE
- 47530
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Andrew Charles Foy
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-11-30
- Letzte Einreichung: 2021-02-28
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-10-12
- Letzte Einreichung: 2020-09-28
-
FOYCOL LIMITED Firmenbeschreibung
- FOYCOL LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06384273. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 28.09.2007 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47530" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 28/02/2012 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Ashley House erreicht werden.
Jetzt sichern FOYCOL LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Foycol Limited - Ashley House, 415 Halifax Road, Brighouse, Yorkshire, Grossbritannien
- 2007-09-28
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu FOYCOL LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-10-15) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-10-12) - AD01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-27) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-07-29) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-11-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-25) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-08) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-09-26) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-08-22) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-07-25) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-09-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-08-15) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-11-30) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-30) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2015-10-04) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-08-18) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-08-18) - TM01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-08-18) - AP03
-
capital-cancellation-shares (2015-08-18) - SH06
-
resolution (2015-08-18) - RESOLUTIONS
-
capital-return-purchase-own-shares (2015-08-18) - SH03
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-14) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-10-14) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2014-11-25) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-18) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2013-10-04) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-02) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2012-09-26) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2011-11-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-11-02) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2010-07-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-11-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-10-29) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2009-06-23) - AA
-
legacy (2009-06-01) - 395
-
legacy (2009-04-08) - 395
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-12-22) - 225
-
legacy (2008-11-06) - 363a
-
legacy (2008-03-28) - 395
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-10-25) - 88(2)R
-
legacy (2007-10-09) - 288b
-
incorporation-company (2007-09-28) - NEWINC