-
BORDER VENDING GROUP LIMITED - Fairview House, Victoria Place, Carlisle, Cumbria, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06357748
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Fairview House
- Victoria Place
- Carlisle
- Cumbria
- CA1 1HP Fairview House, Victoria Place, Carlisle, Cumbria, CA1 1HP UK
Management
- Geschäftsführung
- CALLWOOD, Richard Michael
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 31.08.2007
- Alter der Firma 2007-08-31 16 Jahre
- SIC/NACE
- 46380
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Amanda Louise Drysdale
- Mr Richard Michael Callwood
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- BEDE SERVICES LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-03-31
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-08-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-09-05
- Letzte Einreichung: 2020-08-22
-
BORDER VENDING GROUP LIMITED Firmenbeschreibung
- BORDER VENDING GROUP LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06357748. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 31.08.2007 registriert. BORDER VENDING GROUP LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen BEDE SERVICES LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46380" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 31.08.2012.Die Firma kann schriftlich über Fairview House erreicht werden.
Jetzt sichern BORDER VENDING GROUP LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Border Vending Group Limited - Fairview House, Victoria Place, Carlisle, Cumbria, Grossbritannien
- 2007-08-31
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BORDER VENDING GROUP LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-09-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-09-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-20) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-09-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-01-05) - AA
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-12-17) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-12-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-09-26) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-11) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-08-20) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-09-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-01-04) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-02-27) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-09-06) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-09-06) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-06) - AR01
-
certificate-change-of-name-company (2013-11-12) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2013-11-12) - CONNOT
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-12-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-05) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2011-10-04) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-10-04) - AD01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2011-01-12) - DISS40
-
gazette-notice-compulsary (2011-01-11) - GAZ1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-01-07) - AR01
-
termination-secretary-company-with-name (2011-01-06) - TM02
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-12-30) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-07-02) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-07-01) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2010-07-01) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2010-02-03) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-02-12) - 288b
-
re-registration-memorandum-articles (2009-03-20) - MAR
-
legacy (2009-03-20) - 53
-
resolution (2009-03-20) - RESOLUTIONS
-
miscellaneous (2009-03-20) - MISC
-
legacy (2009-09-10) - 287
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-10-16) - AR01
-
legacy (2009-05-19) - 225
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-01-14) - 288b
-
legacy (2008-07-17) - 225
-
legacy (2008-09-29) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-full (2008-10-02) - AA
-
legacy (2008-10-13) - 288c
-
legacy (2008-09-03) - 288a
keyboard_arrow_right 2007
-
certificate-change-of-name-company (2007-12-27) - CERTNM
-
legacy (2007-10-23) - 225
-
legacy (2007-10-23) - 88(2)R
-
legacy (2007-10-15) - 288a
-
legacy (2007-10-12) - 288b
-
legacy (2007-10-12) - 288a
-
legacy (2007-09-25) - 288a
-
incorporation-company (2007-08-31) - NEWINC