-
ROSTRA HEALTHCARE LTD - 26 Bridge Street, Penistone, Sheffield, S36 6AJ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06337685
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 26 Bridge Street
- Penistone
- Sheffield
- S36 6AJ
- England 26 Bridge Street, Penistone, Sheffield, S36 6AJ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BROWN, Ian Malcolm
- BROWN, Melanie Jean
- Prokuristen
- BROWN, Melanie Jean
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 08.08.2007
- Alter der Firma 2007-08-08 16 Jahre
- SIC/NACE
- 86210
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Melanie Jean Brown
- Mr Ian Malcolm Brown
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-01-31
- Letzte Einreichung: 2019-04-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-08-22
- Letzte Einreichung: 2019-08-08
-
ROSTRA HEALTHCARE LTD Firmenbeschreibung
- ROSTRA HEALTHCARE LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06337685. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 08.08.2007 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "86210" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30.04.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 26 Bridge Street erreicht werden.
Jetzt sichern ROSTRA HEALTHCARE LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Rostra Healthcare Ltd - 26 Bridge Street, Penistone, Sheffield, S36 6AJ, Grossbritannien
- 2007-08-08
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ROSTRA HEALTHCARE LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-31) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-02-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-08-13) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-14) - CS01
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-04-24) - AAMD
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-02-28) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-09-04) - CS01
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-04-19) - AAMD
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-02-24) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-02-07) - AD01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-31) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-12-05) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-23) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
capital-cancellation-shares (2014-11-07) - SH06
-
resolution (2014-11-07) - RESOLUTIONS
-
capital-return-purchase-own-shares (2014-11-07) - SH03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-22) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-09-22) - TM01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2014-07-12) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-09) - AA
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2014-06-21) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsary (2014-04-29) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-29) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-09-29) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2013-09-29) - CH03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-05-07) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-07) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date (2013-05-07) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-05-07) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2013-05-07) - CH03
-
administrative-restoration-company (2013-05-07) - RT01
keyboard_arrow_right 2010
-
gazette-notice-compulsary (2010-05-04) - GAZ1
-
gazette-dissolved-compulsary (2010-08-17) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-09-17) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-03-04) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-10-17) - 363s
keyboard_arrow_right 2007
-
resolution (2007-11-19) - RESOLUTIONS
-
legacy (2007-11-19) - 288a
-
legacy (2007-11-19) - 88(2)R
-
legacy (2007-11-15) - 88(3)
-
legacy (2007-11-15) - 88(2)R
-
legacy (2007-09-09) - 225
-
legacy (2007-09-09) - 88(2)R
-
incorporation-company (2007-08-08) - NEWINC