-
MELROB-GROVE LIMITED - Jupiter House Warley Hill Business Park, The Drive, Brentwood, Essex, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06283780
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Jupiter House Warley Hill Business Park
- The Drive
- Brentwood
- Essex
- CM13 3BE Jupiter House Warley Hill Business Park, The Drive, Brentwood, Essex, CM13 3BE UK
Management
- Geschäftsführung
- BURNEY, Edward Charles
- IBBOTSON, Martin
- MELLUISH, Ian Paul
- Prokuristen
- IBBOTSON, Martin
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 18.06.2007
- Gelöscht am:
- 2018-04-10
- SIC/NACE
- 10860
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- GROVE NUTRITION LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit:
- Letzte Einreichung: 2013-09-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-06-17
-
MELROB-GROVE LIMITED Firmenbeschreibung
- MELROB-GROVE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06283780. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 18.06.2007 registriert. MELROB-GROVE LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen GROVE NUTRITION LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "10860" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30/09/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 17.06.2013.Die Firma kann schriftlich über Jupiter House Warley Hill Business Park erreicht werden.
Jetzt sichern MELROB-GROVE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Melrob-Grove Limited - Jupiter House Warley Hill Business Park, The Drive, Brentwood, Essex, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MELROB-GROVE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2018
-
gazette-dissolved-liquidation (2018-04-10) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2018-01-10) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-05-16) - MR04
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-02-22) - 4.68
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-04-29) - MR04
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2016-01-12) - 600
-
liquidation-in-administration-progress-report-with-brought-down-date (2016-01-12) - 2.24B
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-06-23) - AD01
-
liquidation-in-administration-result-creditors-meeting (2015-07-16) - 2.23B
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2015-06-16) - 2.12B
-
liquidation-in-administration-move-to-creditors-voluntary-liquidation (2015-12-30) - 2.34B
-
liquidation-in-administration-statement-of-affairs-with-form-attached (2015-08-21) - 2.16B
-
liquidation-in-administration-proposals (2015-06-19) - 2.17B
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-31) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2014-07-02) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-06-25) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-06-14) - MR01
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2013-04-26) - AP03
-
certificate-change-of-name-company (2013-10-02) - CERTNM
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-06) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-08-06) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2013-08-06) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-06-12) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-04-26) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-04-26) - AD01
-
termination-director-company-with-name (2013-04-26) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name (2013-04-26) - TM02
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-06) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-31) - AR01
-
change-sail-address-company-with-old-address (2012-07-31) - AD02
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-12-15) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-06-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-11-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-06-17) - AR01
-
move-registers-to-sail-company (2010-06-17) - AD03
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-06-17) - CH01
-
change-sail-address-company (2010-06-17) - AD02
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-03-12) - 225
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-03-16) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-12-15) - AA
-
legacy (2009-06-17) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-06-24) - 363a
-
legacy (2008-06-23) - 288c
-
legacy (2008-01-22) - 288a
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-09-06) - 395
-
legacy (2007-07-25) - 288a
-
legacy (2007-07-25) - 88(2)R
-
legacy (2007-07-25) - 287
-
legacy (2007-07-25) - 288b
-
incorporation-company (2007-06-18) - NEWINC