-
WINLAND CARE LTD - 109 Swan Street, Sileby, LE12 7NN, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06245716
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 109 Swan Street
- Sileby
- LE12 7NN 109 Swan Street, Sileby, LE12 7NN UK
Management
- Geschäftsführung
- CUMBERLAND, Nigel Ewan
- CUMBERLAND, Susan Kim
- WINLOW, Sheila
- Prokuristen
- WINLOW, Sheila
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 14.05.2007
- Gelöscht am:
- 2021-01-15
- SIC/NACE
- 64209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Sheila Winlow
- Mrs Sheila Winlow
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-08-31
- Letzte Einreichung: 2019-11-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-05-14
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-06-11
- Letzte Einreichung: 2019-05-28
-
WINLAND CARE LTD Firmenbeschreibung
- WINLAND CARE LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06245716. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 14.05.2007 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64209" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/05/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 14.05.2012.Die Firma kann schriftlich über 109 Swan Street erreicht werden.
Jetzt sichern WINLAND CARE LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Winland Care Ltd - 109 Swan Street, Sileby, LE12 7NN, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu WINLAND CARE LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-dissolved-liquidation (2021-01-15) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-members-return-of-final-meeting (2020-10-15) - LIQ13
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2020-03-10) - LIQ01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-02) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-02-11) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2020-02-11) - CH03
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-01-15) - MR04
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-03-10) - 600
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-03-11) - AD01
-
resolution (2020-05-19) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2019
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-12-12) - PSC04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-12-12) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2019-11-20) - AA01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-11-19) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-05-15) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-21) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-05-16) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-11) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-18) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-09-07) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-28) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-06-09) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-group (2014-03-03) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-23) - AR01
-
capital-allotment-shares (2013-05-23) - SH01
-
second-filing-of-form-with-form-type-made-up-date (2013-06-07) - RP04
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-small (2012-12-04) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-16) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-02-20) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-06-02) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-06-08) - AR01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2011-06-02) - CH03
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-09-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-05-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-small (2009-02-17) - AA
-
legacy (2009-05-18) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-10-19) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-05-29) - 363a
-
legacy (2008-04-25) - 395
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-06-19) - 88(2)R
-
incorporation-company (2007-05-14) - NEWINC
-
legacy (2007-05-29) - 287
-
legacy (2007-05-29) - 288b
-
legacy (2007-06-19) - 288a
-
legacy (2007-07-03) - 288a
-
legacy (2007-09-05) - 395