-
RGM (QC) LIMITED - Pearl Assurance House, 319 Ballards Lane, London, N12 8LY, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06229351
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Pearl Assurance House
- 319 Ballards Lane
- London
- N12 8LY Pearl Assurance House, 319 Ballards Lane, London, N12 8LY UK
Management
- Geschäftsführung
- MCGREGOR, Robert Grantham
- MCGREGOR, Sally Margaret, Professor
- Prokuristen
- MCGREGOR, Robert Grantham
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 27.04.2007
- Alter der Firma 2007-04-27 17 Jahre
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2017-01-28
- Letzte Einreichung: 2015-04-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2015-04-27
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2017-05-11
- Letzte Einreichung:
-
RGM (QC) LIMITED Firmenbeschreibung
- RGM (QC) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06229351. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 27.04.2007 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30.04.2015 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 27.04.2015.Die Firma kann schriftlich über Pearl Assurance House erreicht werden.
Jetzt sichern RGM (QC) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Rgm (Qc) Limited - Pearl Assurance House, 319 Ballards Lane, London, N12 8LY, Grossbritannien
- 2007-04-27
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu RGM (QC) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2024-06-01) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2023
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2023-05-23) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2022-05-24) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-06-23) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-06-09) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-05-24) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-06-08) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-06-01) - 4.68
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-03-24) - MR04
keyboard_arrow_right 2016
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-01-28) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-12) - AA
-
resolution (2016-04-12) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2016-04-12) - 600
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-04-18) - AD01
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2016-04-12) - 4.70
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-15) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-11) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-01-30) - AA01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-22) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-04) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
legacy (2013-02-26) - MG02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-23) - AR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2013-05-23) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-small (2013-03-05) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-27) - AR01
-
capital-allotment-shares (2012-09-27) - SH01
-
resolution (2012-07-10) - RESOLUTIONS
-
statement-of-companys-objects (2012-07-10) - CC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-03-02) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-05-19) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-05-19) - AR01
-
legacy (2011-09-10) - MG01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-03-02) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-07-01) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-07-01) - CH01
-
miscellaneous (2010-05-24) - MISC
keyboard_arrow_right 2009
-
gazette-notice-compulsary (2009-05-26) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-05-26) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2009-05-27) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-10-31) - AA
-
legacy (2009-06-11) - 288a
-
legacy (2009-06-03) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-10-03) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
incorporation-company (2007-04-27) - NEWINC
-
legacy (2007-05-18) - 395