-
ALPINE PAINTING CONTRACTORS LTD - Airport House, Suite 43-45, Purley Way, Croydon, Surrey, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06199132
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Airport House
- Suite 43-45, Purley Way
- Croydon
- Surrey
- CR0 0XZ Airport House, Suite 43-45, Purley Way, Croydon, Surrey, CR0 0XZ UK
Management
- Geschäftsführung
- FARRINGTON, Trevor
- Prokuristen
- FARRINGTON, Claire
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 02.04.2007
- Alter der Firma 2007-04-02 17 Jahre
- SIC/NACE
- 43341
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Trevor Farrington
- Mr Trevor Farrington
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-10-29
- Letzte Einreichung: 2018-10-29
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-04-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-05-14
- Letzte Einreichung: 2020-04-30
-
ALPINE PAINTING CONTRACTORS LTD Firmenbeschreibung
- ALPINE PAINTING CONTRACTORS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06199132. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 02.04.2007 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43341" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30/04/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 30.04.2012.Die Firma kann schriftlich über Airport House erreicht werden.
Jetzt sichern ALPINE PAINTING CONTRACTORS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Alpine Painting Contractors Ltd - Airport House, Suite 43-45, Purley Way, Croydon, Surrey, Grossbritannien
- 2007-04-02
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ALPINE PAINTING CONTRACTORS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-notice-voluntary (2020-11-17) - GAZ1(A)
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-25) - CS01
-
dissolution-application-strike-off-company (2020-11-10) - DS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-03) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2019-04-02) - AA01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-01-25) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-08) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-07) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-28) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-09) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-05-07) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-28) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-30) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-03) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2014-06-19) - AP03
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-05) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-10-02) - AA
-
termination-director-company-with-name (2012-08-29) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-08) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-01-17) - AA
-
termination-secretary-company-with-name (2012-08-24) - TM02
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-05-10) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-02-10) - AD01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-01-11) - AA
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2010-05-17) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-05-17) - CH01
-
legacy (2010-04-23) - MG01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-05-26) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-11-17) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-07-23) - 363a
-
legacy (2009-03-23) - 287
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-01-31) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-05-22) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-07-17) - 288a
-
legacy (2007-07-16) - 288b
-
legacy (2007-06-26) - 288a
-
incorporation-company (2007-04-02) - NEWINC