-
PANORAMIC LEASE LIMITED - 152 Grosvenor Road, London, SW1 3JL, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06194482
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 152 Grosvenor Road
- London
- SW1 3JL 152 Grosvenor Road, London, SW1 3JL UK
Management
- Geschäftsführung
- ATTARD, Vladimijr Arnold
- BEVERLEY, Michael
- FEINSTEIN, Leonard
- LOVATT, Douglas John
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 30.03.2007
- Alter der Firma 2007-03-30 17 Jahre
- SIC/NACE
- 98000
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-12-31
- Letzte Einreichung: 2021-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-03-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-04-13
- Letzte Einreichung: 2021-03-30
-
PANORAMIC LEASE LIMITED Firmenbeschreibung
- PANORAMIC LEASE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06194482. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 30.03.2007 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "98000" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 30.03.2012.Die Firma kann schriftlich über 152 Grosvenor Road erreicht werden.
Jetzt sichern PANORAMIC LEASE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Panoramic Lease Limited - 152 Grosvenor Road, London, SW1 3JL, Grossbritannien
- 2007-03-30
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PANORAMIC LEASE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
memorandum-articles (2022-01-05) - MA
-
resolution (2022-01-05) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-02-19) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-07) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-08-10) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-10-07) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-04-09) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-16) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-12-17) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-06) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-08-08) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-03) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-11-09) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-11-29) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-10-06) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2015-09-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2014-06-04) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2013-08-27) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-30) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2012-10-09) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-05-26) - AR01
-
capital-allotment-shares (2011-05-27) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2011-07-11) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2010-10-20) - AA
-
termination-secretary-company-with-name (2010-04-29) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-04-26) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-04-26) - CH01
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2010-04-26) - CH04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-02-06) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2010-01-26) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-06-17) - 88(2)
-
resolution (2009-06-17) - RESOLUTIONS
-
legacy (2009-04-06) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2009-01-31) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-05-20) - 363a
-
legacy (2008-06-25) - 288a
-
legacy (2008-02-21) - 288b
-
legacy (2008-07-22) - 288b
-
legacy (2008-05-09) - 288a
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-10-09) - 395
-
incorporation-company (2007-03-30) - NEWINC
-
legacy (2007-10-10) - 288c