-
PORTFOLIO DIRECTORS LIMITED - ROSY JEFFERY LTD, The Loft Unit 11, Hunthay Business Park, Axminster, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06156084
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- ROSY JEFFERY LTD
- The Loft Unit 11
- Hunthay Business Park
- Axminster
- Devon
- EX13 5RJ
- England ROSY JEFFERY LTD, The Loft Unit 11, Hunthay Business Park, Axminster, Devon, EX13 5RJ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- WARREN, Emma Louise
- Prokuristen
- WARREN, Emma
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.03.2007
- Alter der Firma 2007-03-13 17 Jahre
- SIC/NACE
- 74909
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Emma Louise Warren
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-12-31
- Letzte Einreichung: 2021-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-03-27
- Letzte Einreichung: 2022-03-13
-
PORTFOLIO DIRECTORS LIMITED Firmenbeschreibung
- PORTFOLIO DIRECTORS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06156084. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 13.03.2007 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74909" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Rosy Jeffery Ltd erreicht werden.
Jetzt sichern PORTFOLIO DIRECTORS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Portfolio Directors Limited - ROSY JEFFERY LTD, The Loft Unit 11, Hunthay Business Park, Axminster, Grossbritannien
- 2007-03-13
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PORTFOLIO DIRECTORS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-03-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-03-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-23) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-22) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-07-06) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-29) - AA
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2017-07-06) - CH03
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-20) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-09) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-24) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-07-20) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
second-filing-of-form-with-form-type-made-up-date (2014-04-11) - RP04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-23) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-02-11) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
resolution (2013-04-18) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-30) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2012-09-10) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-20) - AR01
-
termination-secretary-company-with-name (2012-03-19) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2012-03-19) - AP03
keyboard_arrow_right 2011
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2011-04-21) - CH03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-10-03) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-04-21) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-04-21) - CH01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-09-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-04-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-03-24) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-10-08) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-11-01) - AA
-
legacy (2008-04-04) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-05-22) - 288a
-
incorporation-company (2007-03-13) - NEWINC
-
legacy (2007-10-30) - 288c
-
legacy (2007-03-26) - 288b
-
legacy (2007-11-20) - 288a
-
legacy (2007-11-19) - 288b
-
legacy (2007-03-26) - 225