-
HITCHCOCKS BUSINESS PARK LIMITED - Hitchcocks Hq, Hitchcocks Business Park, Willand, Devon, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06135328
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Hitchcocks Hq
- Hitchcocks Business Park
- Willand
- Devon
- EX15 3FA
- United Kingdom Hitchcocks Hq, Hitchcocks Business Park, Willand, Devon, EX15 3FA, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- PERSEY, Richard Alan William
- PERSEY, Jemma
- Prokuristen
- PERSEY, Richard Alan William
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 02.03.2007
- Alter der Firma 2007-03-02 17 Jahre
- SIC/NACE
- 01500
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- Hitchcocks Group Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- LANGLANDS FARMS LIMITED
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 213800MQ5VSMZ1TJT637
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-30
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-10-29
- Letzte Einreichung: 2021-10-15
-
HITCHCOCKS BUSINESS PARK LIMITED Firmenbeschreibung
- HITCHCOCKS BUSINESS PARK LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06135328. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 02.03.2007 registriert. HITCHCOCKS BUSINESS PARK LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen LANGLANDS FARMS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "01500" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Hitchcocks Hq erreicht werden.
Jetzt sichern HITCHCOCKS BUSINESS PARK LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Hitchcocks Business Park Limited - Hitchcocks Hq, Hitchcocks Business Park, Willand, Devon, Grossbritannien
- 2007-03-02
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HITCHCOCKS BUSINESS PARK LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
capital-allotment-shares (2021-03-10) - SH01
-
legacy (2021-03-02) - CAP-SS
-
resolution (2021-03-02) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2021-02-23) - MA
-
resolution (2021-02-23) - RESOLUTIONS
-
legacy (2021-02-22) - SH20
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2021-02-22) - SH19
-
legacy (2021-02-22) - CAP-SS
-
resolution (2021-02-22) - RESOLUTIONS
-
capital-name-of-class-of-shares (2021-02-22) - SH08
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2021-03-02) - SH19
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-03-09) - TM01
-
legacy (2021-03-02) - SH20
-
confirmation-statement-with-updates (2021-03-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-03-29) - AA
-
resolution (2021-04-01) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-10-23) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-10-23) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-03-09) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-03-09) - PSC02
keyboard_arrow_right 2020
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-04-20) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-03-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-02-05) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-14) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-20) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-12-19) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-10-12) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-10-12) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2017-05-23) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-12-29) - AA
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2017-07-01) - DISS16(SOAS)
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-10-14) - DISS40
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-30) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-29) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-06-01) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-31) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-05-31) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2016-05-31) - CH03
-
gazette-notice-compulsory (2016-05-31) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2015
-
administrative-restoration-company (2015-09-09) - RT01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-09) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
gazette-dissolved-compulsory (2009-08-11) - GAZ2
-
gazette-notice-compulsory (2009-04-28) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2009-01-13) - DISS40
-
legacy (2009-01-12) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
gazette-notice-compulsory (2008-12-30) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-03-14) - 288b