-
FAIRTECH ENGINEERING SERVICES LIMITED - St George's Lodge, Oldfield Road, Bath, BA2 3NE, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06084111
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- St George's Lodge
- Oldfield Road
- Bath
- BA2 3NE
- England St George's Lodge, Oldfield Road, Bath, BA2 3NE, England UK
Management
- Geschäftsführung
- SRINIVASAN, Subramani
- Prokuristen
- RANGASAMY, Dhanalakshmi
- SRINIVASAN, Subramani
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.02.2007
- Gelöscht am:
- 2021-05-18
- SIC/NACE
- 74100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Subramani Srinivasan
- Mr Subramani Srinivasan
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-03-31
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2014-02-06
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-02-20
- Letzte Einreichung: 2019-02-06
-
FAIRTECH ENGINEERING SERVICES LIMITED Firmenbeschreibung
- FAIRTECH ENGINEERING SERVICES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06084111. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 06.02.2007 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 2 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 06.02.2014.Die Firma kann schriftlich über St George's Lodge erreicht werden.
Jetzt sichern FAIRTECH ENGINEERING SERVICES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Fairtech Engineering Services Limited - St George's Lodge, Oldfield Road, Bath, BA2 3NE, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu FAIRTECH ENGINEERING SERVICES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-01-11) - AD01
-
gazette-dissolved-compulsory (2021-05-18) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2020
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2020-12-12) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2020-11-03) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2019
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-05-04) - DISS40
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-02) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2019-04-30) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-20) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-12-03) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-22) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-03-20) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-03-20) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-03-20) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2017-09-27) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-27) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-18) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-23) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-02-23) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2015-02-22) - CH03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-02-03) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-27) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-11-10) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-01) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-24) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-11-15) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-11-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-11-17) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-02-17) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-02-17) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-09-16) - AA
-
legacy (2009-02-16) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-02-18) - 287
-
legacy (2008-04-02) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-11-17) - AA
-
legacy (2008-06-12) - 288a
keyboard_arrow_right 2007
-
incorporation-company (2007-02-06) - NEWINC
-
legacy (2007-10-17) - 287
-
legacy (2007-06-20) - 288a
-
legacy (2007-06-19) - 288b
-
legacy (2007-06-04) - 225