-
YOGALAND LTD - 1 Lilley Mead, Redhill, Surrey, RH1 2NY, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06056463
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1 Lilley Mead
- Redhill
- Surrey
- RH1 2NY
- England 1 Lilley Mead, Redhill, Surrey, RH1 2NY, England UK
Management
- Geschäftsführung
- DEITH, Leon Robert
- SHARMA, Rajneesh
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.01.2007
- Alter der Firma 2007-01-17 17 Jahre
- SIC/NACE
- 47190
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Leon Robert Deith
- Mr Rajneesh Sharma
- Mr Rajneesh Sharma
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- YOGA TREATS LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-10-31
- Letzte Einreichung: 2020-01-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-17
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-01-31
- Letzte Einreichung: 2021-01-17
-
YOGALAND LTD Firmenbeschreibung
- YOGALAND LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06056463. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.01.2007 registriert. YOGALAND LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen YOGA TREATS LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47190" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/01/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 17.01.2013.Die Firma kann schriftlich über 1 Lilley Mead erreicht werden.
Jetzt sichern YOGALAND LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Yogaland Ltd - 1 Lilley Mead, Redhill, Surrey, RH1 2NY, Grossbritannien
- 2007-01-17
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu YOGALAND LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-01-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-29) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-10-22) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-10-16) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-10-03) - CH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-02-05) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-30) - CS01
-
capital-allotment-shares (2018-01-30) - SH01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-10-27) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-17) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-10-24) - AD01
keyboard_arrow_right 2016
-
resolution (2016-11-04) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-19) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-01-19) - CH01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-03) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-amended-with-made-up-date (2013-10-22) - AAMD
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-25) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-19) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-12-12) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2012-12-11) - CERTNM
-
termination-secretary-company-with-name (2012-12-11) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-11-19) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-01-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-10-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-01-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-10-18) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-01-25) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-01-25) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-02-06) - 363a
-
legacy (2009-04-15) - 288b
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-09-11) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2008-10-20) - AA
-
legacy (2008-10-17) - 363a
-
legacy (2008-10-17) - 288c
-
legacy (2008-01-30) - 288b
-
legacy (2008-01-15) - 288a
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-09-04) - 287
-
legacy (2007-11-09) - 288a
-
incorporation-company (2007-01-17) - NEWINC
-
legacy (2007-01-18) - 288b
-
legacy (2007-11-09) - 88(2)R
-
resolution (2007-01-30) - RESOLUTIONS