-
SWINTON RUGBY LEAGUE FOOTBALL CLUB LIMITED - Unit 2, Railway Court, Ten Pound Walk, Doncaster, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06045563
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 2
- Railway Court
- Ten Pound Walk
- Doncaster
- DN4 5FB Unit 2, Railway Court, Ten Pound Walk, Doncaster, DN4 5FB UK
Management
- Geschäftsführung
- KIDD, David John
- KIDD, David Paul
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.01.2007
- Alter der Firma 2007-01-09 17 Jahre
- SIC/NACE
- 93120
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2014-10-31
- Letzte Einreichung: 2013-01-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-09
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2017-01-23
- Letzte Einreichung:
-
SWINTON RUGBY LEAGUE FOOTBALL CLUB LIMITED Firmenbeschreibung
- SWINTON RUGBY LEAGUE FOOTBALL CLUB LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06045563. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 09.01.2007 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "93120" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/01/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 09.01.2013.Die Firma kann schriftlich über Unit 2 erreicht werden.
Jetzt sichern SWINTON RUGBY LEAGUE FOOTBALL CLUB LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Swinton Rugby League Football Club Limited - Unit 2, Railway Court, Ten Pound Walk, Doncaster, Grossbritannien
- 2007-01-09
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SWINTON RUGBY LEAGUE FOOTBALL CLUB LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-11-05) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-01-05) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-12-04) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-12-21) - AD01
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-10-26) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2016-12-16) - 4.68
-
liquidation-voluntary-arrangement-completion (2016-02-16) - 1.4
keyboard_arrow_right 2015
-
liquidation-cva-supervisors-abstract-of-receipts-payments-with-brought-down-date (2015-03-18) - 1.3
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-20) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-09-11) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-05-07) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2015-10-16) - 4.20
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2015-10-16) - 600
-
resolution (2015-10-16) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2014
-
liquidation-voluntary-arrangement-meeting-approving-companies-voluntary-arrangement (2014-01-21) - 1.1
-
termination-secretary-company-with-name (2014-01-08) - TM02
keyboard_arrow_right 2013
-
termination-director-company-with-name (2013-11-15) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-10-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-01-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
termination-director-company-with-name (2011-11-14) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-10-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-01-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-10-30) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-03-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-03-05) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-03-05) - CH01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2010-02-04) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name (2010-02-03) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-02-03) - AR01
-
legacy (2010-02-02) - MG01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-03-19) - 288a
-
legacy (2009-04-15) - 288b
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2009-03-19) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-08-15) - 288a
-
legacy (2008-08-14) - 288a
-
legacy (2008-04-15) - 363s
-
legacy (2008-04-15) - 288a
-
legacy (2008-04-08) - 288a
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-07-25) - 288b
-
legacy (2007-06-03) - 88(2)R
-
legacy (2007-03-20) - 288a
-
legacy (2007-03-20) - 288b
-
incorporation-company (2007-01-09) - NEWINC