-
PERFUME PLUS DIRECT LTD - 61 Stanley Road, Whitefield, Manchester, M45 8GZ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06035227
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 61 Stanley Road
- Whitefield
- Manchester
- M45 8GZ
- England 61 Stanley Road, Whitefield, Manchester, M45 8GZ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- SOWDEN, Emma Jean
- SHARMAN, John William
- SHARMAN, Stephen John
- Prokuristen
- SOWDEN, Emma Jean
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 21.12.2006
- Alter der Firma 2006-12-21 17 Jahre
- SIC/NACE
- 47910
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-21
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-01-04
- Letzte Einreichung: 2023-12-21
-
PERFUME PLUS DIRECT LTD Firmenbeschreibung
- PERFUME PLUS DIRECT LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06035227. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 21.12.2006 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47910" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2022 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 21.12.2012.Die Firma kann schriftlich über 61 Stanley Road erreicht werden.
Jetzt sichern PERFUME PLUS DIRECT LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Perfume Plus Direct Ltd - 61 Stanley Road, Whitefield, Manchester, M45 8GZ, Grossbritannien
- 2006-12-21
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PERFUME PLUS DIRECT LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-12-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-06-08) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-01-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-02-21) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-04-04) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2021-01-05) - PSC08
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-22) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-12-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-09-16) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-12-23) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-12-21) - CS01
-
capital-allotment-shares (2020-12-23) - SH01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-08-23) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-21) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-01-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-08-07) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-08-07) - AP03
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-08-07) - CH01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-08-07) - TM02
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-15) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-04) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-11-21) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-01) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2014-12-10) - CH03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-15) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-05-14) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-01-13) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-06-01) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-04-19) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-01-13) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-09-13) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-04-19) - AD01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-09-07) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-01-12) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-01-12) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-amended-with-made-up-date (2009-05-27) - AAMD
-
legacy (2009-01-16) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2009-01-12) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2008-01-15) - AA
-
legacy (2008-01-07) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-10-16) - 288a
-
legacy (2007-10-15) - 288a
-
legacy (2007-10-15) - 288b
-
legacy (2007-10-15) - 287
keyboard_arrow_right 2006
-
incorporation-company (2006-12-21) - NEWINC