-
GEORGE LEWIS DESIGN AND BUILD LIMITED - Unit 4, The Maltings, Millfield Cottenham, Cambridge, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06022431
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 4
- The Maltings
- Millfield Cottenham
- Cambridge
- CB24 8RE Unit 4, The Maltings, Millfield Cottenham, Cambridge, CB24 8RE UK
Management
- Geschäftsführung
- BROWN, Jacqueline Lee Patricia
- BROWN, Peter John
- Prokuristen
- BROWN, Jacqueline Lee Patricia
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.12.2006
- Alter der Firma 2006-12-07 17 Jahre
- SIC/NACE
- 43390
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Peter John Brown
- Jacqueline Lee Patricia Brown
- James Frederick Matthews
- Susan Mary Matthews
- Mrs Susan Mary Matthews
- Jacqueline Lee Patricia Brown
- Peter John Brown
- James Frederick Matthews
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-07
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-10-17
- Letzte Einreichung: 2019-09-05
-
GEORGE LEWIS DESIGN AND BUILD LIMITED Firmenbeschreibung
- GEORGE LEWIS DESIGN AND BUILD LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06022431. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 07.12.2006 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43390" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 07.12.2012.Die Firma kann schriftlich über Unit 4 erreicht werden.
Jetzt sichern GEORGE LEWIS DESIGN AND BUILD LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: George Lewis Design And Build Limited - Unit 4, The Maltings, Millfield Cottenham, Cambridge, Grossbritannien
- 2006-12-07
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu GEORGE LEWIS DESIGN AND BUILD LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
mortgage-create-with-deed (2020-10-01) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-02-19) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2020-02-19) - TM02
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-02-21) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-09-24) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-08-12) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-09-16) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-09-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-05) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-12-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-27) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2016-11-30) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-11-30) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-25) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-23) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-12-23) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-18) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-18) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-18) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-10) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-08-10) - AA
-
legacy (2012-06-27) - MG01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-12-08) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-12-08) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-09-30) - AA
-
legacy (2010-03-26) - MG01
keyboard_arrow_right 2009
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-12-22) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-10-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-12-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-12-11) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-10-06) - AA
-
legacy (2008-01-07) - 363a
-
legacy (2008-01-07) - 288c
-
legacy (2008-01-04) - 288c
-
legacy (2008-01-04) - 287
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-11-23) - 395
-
legacy (2007-10-26) - 395
-
legacy (2007-03-02) - 288a
keyboard_arrow_right 2006
-
incorporation-company (2006-12-07) - NEWINC