-
REBOUND NORTH LIMITED - Rivergate House, Newbury Business Park, Newbury, Berkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06015523
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Rivergate House
- Newbury Business Park
- Newbury
- Berkshire
- RG14 2PZ
- England Rivergate House, Newbury Business Park, Newbury, Berkshire, RG14 2PZ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- COPELY, Nigel Dorrien
- GRIFFITH-JONES, Peter Laugharne
- MADLEY, Stephen John
- Prokuristen
- TAYLOR, Cecilia
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 01.12.2006
- Gelöscht am:
- 2023-01-17
- SIC/NACE
- 46520
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Rebound Technology Group Holdings Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-04-13
- Letzte Einreichung: 2021-03-30
-
REBOUND NORTH LIMITED Firmenbeschreibung
- REBOUND NORTH LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06015523. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 01.12.2006 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46520" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Rivergate House erreicht werden.
Jetzt sichern REBOUND NORTH LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Rebound North Limited - Rivergate House, Newbury Business Park, Newbury, Berkshire, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu REBOUND NORTH LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-31) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2021-02-08) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2019-10-25) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-04-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-07-17) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-12-06) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-06-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-12) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-30) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-09-05) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-02-09) - CH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-11-10) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-11-04) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
resolution (2015-08-25) - RESOLUTIONS
-
capital-return-purchase-own-shares (2015-08-25) - SH03
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-08-10) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-08-03) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-10-02) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2013-09-10) - AA
-
capital-return-purchase-own-shares (2013-07-18) - SH03
-
termination-director-company-with-name (2013-07-01) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-04-19) - MR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-21) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2012-06-26) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-full (2011-06-09) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-01-19) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
memorandum-articles (2010-08-26) - MEM/ARTS
-
resolution (2010-08-26) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-full (2010-07-12) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-09-30) - 288b
-
accounts-with-accounts-type-full (2009-11-04) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-12-29) - CH01
-
legacy (2009-07-02) - 288c
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-12-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-12-12) - 363a
-
legacy (2008-12-11) - 288c
-
accounts-with-accounts-type-full (2008-04-30) - AA
-
legacy (2008-01-11) - 287
keyboard_arrow_right 2007
-
resolution (2007-01-07) - RESOLUTIONS
-
legacy (2007-05-08) - 88(2)R
-
legacy (2007-08-04) - 288a
-
legacy (2007-08-04) - 288b
-
legacy (2007-12-05) - 363a
keyboard_arrow_right 2006
-
incorporation-company (2006-12-01) - NEWINC