-
TREKENNING LIMITED - 53 Fore Street, Ivybridge, Devon, PL21 9AE, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06003783
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 53 Fore Street
- Ivybridge
- Devon
- PL21 9AE 53 Fore Street, Ivybridge, Devon, PL21 9AE UK
Management
- Geschäftsführung
- CHAPMAN, Andrew Frank
- CHAPMAN, Tristan Thomas Ralph
- PARRY, Guy Benjamin
- Prokuristen
- CHAPMAN, Andrew Frank
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.11.2006
- Alter der Firma 2006-11-20 17 Jahre
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Andrew Frank Chapman
- Mr Tristan Thomas Ralph Chapman
- Mr Guy Benjamin Parry
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-02-28
- Letzte Einreichung: 2020-05-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-11-20
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-01-01
- Letzte Einreichung: 2019-11-20
-
TREKENNING LIMITED Firmenbeschreibung
- TREKENNING LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06003783. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 20.11.2006 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 20.11.2012.Die Firma kann schriftlich über 53 Fore Street erreicht werden.
Jetzt sichern TREKENNING LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Trekenning Limited - 53 Fore Street, Ivybridge, Devon, PL21 9AE, Grossbritannien
- 2006-11-20
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu TREKENNING LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
resolution (2020-10-30) - RESOLUTIONS
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2020-06-29) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-08-10) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-10-01) - MR04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-10-02) - AD01
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2020-10-30) - LIQ01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-10-30) - 600
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-08-08) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-09-14) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-08-08) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-20) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-01-26) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-26) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-04) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-02) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-05) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-12-05) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-12) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-10-03) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-10-05) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-09-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-11-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-11-24) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-11-23) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-10-22) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-12-02) - 363a
-
legacy (2008-12-02) - 353
-
legacy (2008-12-02) - 190
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-09-18) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-01-08) - 288b
-
legacy (2007-01-08) - 288a
-
legacy (2007-01-08) - 287
-
legacy (2007-01-16) - 288a
-
legacy (2007-01-18) - 288a
-
legacy (2007-11-04) - 225
-
legacy (2007-11-04) - 88(2)R
-
legacy (2007-12-03) - 288c
-
legacy (2007-12-03) - 363a
-
legacy (2007-03-03) - 395
keyboard_arrow_right 2006
-
incorporation-company (2006-11-20) - NEWINC