-
PEVEREL ENGINEERING DESIGN LTD - The Old Brewhouse 49-51 Brewhouse Hill, Wheathampstead, St Albans, Hertfordshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05968493
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Old Brewhouse 49-51 Brewhouse Hill
- Wheathampstead
- St Albans
- Hertfordshire
- AL4 8AN The Old Brewhouse 49-51 Brewhouse Hill, Wheathampstead, St Albans, Hertfordshire, AL4 8AN UK
Management
- Geschäftsführung
- FABRIS, Valeria
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 16.10.2006
- Gelöscht am:
- 2021-06-30
- SIC/NACE
- 71122
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Dr Massimo Fetti
- Mrs Valeria Fabris
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-07-31
- Letzte Einreichung: 2019-10-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-16
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-11-27
- Letzte Einreichung: 2019-10-16
-
PEVEREL ENGINEERING DESIGN LTD Firmenbeschreibung
- PEVEREL ENGINEERING DESIGN LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05968493. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 16.10.2006 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "71122" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.10.2019 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 16.10.2012.Die Firma kann schriftlich über The Old Brewhouse 49-51 Brewhouse Hill erreicht werden.
Jetzt sichern PEVEREL ENGINEERING DESIGN LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Peverel Engineering Design Ltd - The Old Brewhouse 49-51 Brewhouse Hill, Wheathampstead, St Albans, Hertfordshire, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PEVEREL ENGINEERING DESIGN LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-dissolved-liquidation (2021-06-30) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-members-return-of-final-meeting (2021-03-31) - LIQ13
keyboard_arrow_right 2020
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-03-23) - AD01
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2020-03-19) - LIQ01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-02-17) - AA
-
resolution (2020-03-19) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-03-19) - 600
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-25) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-11-01) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-11-01) - PSC07
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-11-05) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-11-05) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-29) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-06-20) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-07-13) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-16) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-07-13) - TM02
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-21) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-28) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-10-28) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-02) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-04) - AR01
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2014-11-04) - AP04
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2014-11-04) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-23) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-07-11) - AD01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-26) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-05-20) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-07-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2011-07-15) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-10-18) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2010-05-28) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2009-06-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-10-26) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-10-26) - CH01
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-10-31) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2008-07-04) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-10-23) - 363a
-
legacy (2007-01-08) - 288a
-
legacy (2007-01-08) - 288b
keyboard_arrow_right 2006
-
incorporation-company (2006-10-16) - NEWINC