-
METALITE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED - 38, De Montfort Street, Leicester, LE1 7GS, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05934378
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 38
- De Montfort Street
- Leicester
- LE1 7GS 38, De Montfort Street, Leicester, LE1 7GS UK
Management
- Geschäftsführung
- BALDWIN, John Arthur
- JAMES, Lee Julian
- Prokuristen
- JAMES, Lee Julian
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.09.2006
- Alter der Firma 2006-09-13 17 Jahre
- SIC/NACE
- 70100
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2016-11-30
- Letzte Einreichung: 2015-02-28
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2014-09-13
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2016-09-27
- Letzte Einreichung:
-
METALITE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED Firmenbeschreibung
- METALITE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05934378. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 13.09.2006 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 28/02/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 13.09.2014.Die Firma kann schriftlich über 38 erreicht werden.
Jetzt sichern METALITE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Metalite Engineering Holdings Limited - 38, De Montfort Street, Leicester, LE1 7GS, Grossbritannien
- 2006-09-13
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu METALITE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2020-08-20) - LIQ10
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-04-07) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-03-27) - MR04
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-04-05) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-04-10) - LIQ03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-01-18) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2018-01-16) - 600
-
liquidation-voluntary-leave-to-resign-liquidator (2018-01-12) - LIQ07
keyboard_arrow_right 2017
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-08-10) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-04-21) - 4.68
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-02-03) - AD01
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2016-02-23) - 4.20
-
resolution (2016-02-23) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-02-25) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2016-02-23) - 600
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-12) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-21) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-11-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-11-25) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-11-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-10-29) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-05-18) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2010-05-18) - CH03
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-12-29) - AA
-
legacy (2009-09-17) - 363a
-
legacy (2009-09-17) - 287
-
legacy (2009-05-28) - 288a
-
legacy (2009-02-19) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-09-26) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-09-28) - 288a
-
legacy (2007-09-28) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-12-20) - AA
keyboard_arrow_right 2006
-
resolution (2006-10-25) - RESOLUTIONS
-
legacy (2006-10-25) - 225
-
legacy (2006-10-25) - 287
-
legacy (2006-10-25) - 288b
-
legacy (2006-10-25) - 288a
-
legacy (2006-10-23) - 395
-
incorporation-company (2006-09-13) - NEWINC