-
SPARKLE PR LIMITED - Allen House 1 Westmead Road, Sutton, London, SM1 4LA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05934121
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Allen House 1 Westmead Road
- Sutton
- London
- SM1 4LA Allen House 1 Westmead Road, Sutton, London, SM1 4LA UK
Management
- Geschäftsführung
- CAMPLING, Wendy Christine
- HUGGETT, Jacqueline Anne
- SMITH, Nicholas Edward
- Prokuristen
- SMITH, Nicholas Edward
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.09.2006
- Alter der Firma 2006-09-13 17 Jahre
- SIC/NACE
- 73120
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Miss Wendy Christine Campling
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Ehemalige Namen
- FALLPORT LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-06-30
- Letzte Einreichung: 2021-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-11-06
- Letzte Einreichung: 2022-10-23
-
SPARKLE PR LIMITED Firmenbeschreibung
- SPARKLE PR LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05934121. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 13.09.2006 registriert. SPARKLE PR LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen FALLPORT LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "73120" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30.09.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Allen House 1 Westmead Road erreicht werden.
Jetzt sichern SPARKLE PR LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Sparkle Pr Limited - Allen House 1 Westmead Road, Sutton, London, SM1 4LA, Grossbritannien
- 2006-09-13
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SPARKLE PR LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2024-03-03) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2023
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2023-02-18) - LIQ02
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2023-01-11) - CH03
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2023-01-11) - DISS40
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-01-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2023-01-10) - AA
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2023-02-18) - 600
-
resolution (2023-02-18) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-02-20) - AD01
keyboard_arrow_right 2022
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2022-12-09) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2022-11-29) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-10-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-07-24) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-09-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-06-29) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-06-28) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-06-26) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-31) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-09-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-22) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-29) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-30) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-01) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-24) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-07-17) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-01) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-06-27) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-09-20) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-06-24) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-09-28) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-09-28) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-07-01) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-09-14) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-07-24) - AA
-
legacy (2009-07-17) - 395
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-02-12) - 288b
-
legacy (2008-02-12) - 288a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-06-04) - AA
-
legacy (2008-10-29) - 363a
-
legacy (2008-07-02) - 288a
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-10-29) - 363a
-
legacy (2007-08-20) - 287
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-11-28) - 288b
-
legacy (2006-11-28) - 288a
-
resolution (2006-10-12) - RESOLUTIONS
-
certificate-change-of-name-company (2006-10-09) - CERTNM
-
incorporation-company (2006-09-13) - NEWINC