-
TRANS-VITESSE INTERNATIONAL LIMITED - C/O Grant Thornton Uk Llp, 30 Finsbury Square, London, EC2P 2YU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05926916
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Grant Thornton Uk Llp
- 30 Finsbury Square
- London
- EC2P 2YU C/O Grant Thornton Uk Llp, 30 Finsbury Square, London, EC2P 2YU UK
Management
- Geschäftsführung
- GRAVES, Shaun Robert
- HARVEY, Mark
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.09.2006
- Alter der Firma 2006-09-06 17 Jahre
- SIC/NACE
- 9305
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2011-03-31
- Letzte Einreichung: 2009-06-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2009-09-06
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2016-09-20
- Letzte Einreichung:
-
TRANS-VITESSE INTERNATIONAL LIMITED Firmenbeschreibung
- TRANS-VITESSE INTERNATIONAL LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05926916. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 06.09.2006 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "9305" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/06/2009 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 06.09.2009.Die Firma kann schriftlich über C/o Grant Thornton Uk Llp erreicht werden.
Jetzt sichern TRANS-VITESSE INTERNATIONAL LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Trans-Vitesse International Limited - C/O Grant Thornton Uk Llp, 30 Finsbury Square, London, EC2P 2YU, Grossbritannien
- 2006-09-06
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu TRANS-VITESSE INTERNATIONAL LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2024-01-12) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2023
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2023-05-20) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2022-05-18) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-05-28) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-05-20) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-05-25) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-06-06) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-04-20) - 4.68
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2016-06-02) - 4.68
keyboard_arrow_right 2014
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2014-05-29) - 4.68
keyboard_arrow_right 2013
-
liquidation-voluntary-cease-to-act-as-liquidator (2013-03-22) - 4.40
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-04-11) - AD01
-
liquidation-miscellaneous (2013-04-10) - LIQ MISC
-
liquidation-court-order-miscellaneous (2013-12-23) - LIQ MISC OC
-
liquidation-voluntary-cease-to-act-as-liquidator (2013-12-23) - 4.40
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2013-04-10) - 600
keyboard_arrow_right 2012
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2012-04-20) - 600
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2012-04-12) - 600
-
liquidation-in-administration-progress-report-with-brought-down-date (2012-03-26) - 2.24B
-
liquidation-in-administration-move-to-creditors-voluntary-liquidation (2012-03-26) - 2.34B
keyboard_arrow_right 2011
-
liquidation-in-administration-extension-of-period (2011-10-04) - 2.31B
-
liquidation-in-administration-progress-report-with-brought-down-date (2011-10-11) - 2.24B
-
liquidation-in-administration-progress-report-with-brought-down-date (2011-05-17) - 2.24B
keyboard_arrow_right 2010
-
liquidation-in-administration-proposals (2010-12-02) - 2.17B
-
liquidation-in-administration-result-creditors-meeting (2010-12-21) - 2.23B
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-04-06) - AA
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2010-10-13) - 2.12B
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-10-13) - AD01
-
legacy (2010-02-12) - MG01
keyboard_arrow_right 2009
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-11-20) - AR01
-
termination-secretary-company-with-name (2009-11-12) - TM02
-
legacy (2009-09-28) - 288b
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-02-26) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-11-21) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2008-01-14) - AA
-
legacy (2008-01-14) - 225
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-04-05) - 288a
-
legacy (2007-05-02) - 88(2)R
-
legacy (2007-09-24) - 363a
-
legacy (2007-05-02) - 287
keyboard_arrow_right 2006
-
incorporation-company (2006-09-06) - NEWINC
-
legacy (2006-09-14) - 288b
-
legacy (2006-09-14) - 288a
-
legacy (2006-09-14) - 287