-
SAHOTA WINES & CONVENIENCE LTD - Cavendish House, 39-41 Waterloo Street, Birmingham, B2 5PP, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05872658
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Cavendish House
- 39-41 Waterloo Street
- Birmingham
- B2 5PP Cavendish House, 39-41 Waterloo Street, Birmingham, B2 5PP UK
Management
- Geschäftsführung
- SAHOTA, Kuldip Kaur
- SAHOTA, Tarsame Singh
- Prokuristen
- SAHOTA, Kuldip Kaur
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.07.2006
- Gelöscht am:
- 2023-05-22
- SIC/NACE
- 47110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Kuldip Kaur Sahota
- Mr Tarsame Singh Sahota
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-06-30
- Letzte Einreichung: 2020-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-07-25
- Letzte Einreichung: 2020-07-11
-
SAHOTA WINES & CONVENIENCE LTD Firmenbeschreibung
- SAHOTA WINES & CONVENIENCE LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05872658. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 11.07.2006 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47110" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30.09.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Cavendish House erreicht werden.
Jetzt sichern SAHOTA WINES & CONVENIENCE LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Sahota Wines & Convenience Ltd - Cavendish House, 39-41 Waterloo Street, Birmingham, B2 5PP, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SAHOTA WINES & CONVENIENCE LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
gazette-dissolved-liquidation (2023-05-22) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2023-02-22) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2022-06-15) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2022-06-09) - LIQ02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-06-09) - AD01
-
resolution (2022-06-20) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2021
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-07-06) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-06-27) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-07-06) - AD01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-07-29) - PSC04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-07-29) - CS01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2021-07-29) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-07-29) - CH01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-06-23) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-06-19) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-06-27) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-14) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-11) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-15) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-06) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-06-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-17) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-06-30) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-06-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-07-26) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2011-03-03) - AA01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-08-19) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-08-18) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-02-03) - AA
-
capital-allotment-shares (2010-01-18) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-01-21) - AP01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-03-30) - AA
-
legacy (2009-07-13) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-08-13) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-05-09) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-08-29) - 363s
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-07-19) - 288b
-
legacy (2006-07-19) - 288a
-
incorporation-company (2006-07-11) - NEWINC
-
legacy (2006-07-19) - 287