-
PX BIODIESEL IMMINGHAM LIMITED - Px House, Westpoint Road, Stockton On Tees, TS17 6BF, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05807602
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Px House
- Westpoint Road
- Stockton On Tees
- TS17 6BF Px House, Westpoint Road, Stockton On Tees, TS17 6BF UK
Management
- Geschäftsführung
- HOLMES, Geoffrey Robert
- SMAIL, Lee Nadine
- WEATHERILL, Daniel Philip David
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 05.05.2006
- Gelöscht am:
- 2020-03-17
- SIC/NACE
- 20140
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Px Holdings Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit:
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
-
PX BIODIESEL IMMINGHAM LIMITED Firmenbeschreibung
- PX BIODIESEL IMMINGHAM LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05807602. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 05.05.2006 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "20140" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Px House erreicht werden.
Jetzt sichern PX BIODIESEL IMMINGHAM LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Px Biodiesel Immingham Limited - Px House, Westpoint Road, Stockton On Tees, TS17 6BF, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PX BIODIESEL IMMINGHAM LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-voluntary (2020-03-17) - GAZ2(A)
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-14) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-07-10) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-07-10) - AP01
-
gazette-notice-voluntary (2019-12-31) - GAZ1(A)
-
dissolution-application-strike-off-company (2019-12-19) - DS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2019-09-25) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-10-11) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-10-02) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-02) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2017-10-02) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-04-12) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-04-12) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-05-11) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-12) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-09-29) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-05) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-small (2014-09-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-small (2013-09-18) - AA
-
termination-director-company-with-name (2013-08-13) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-07) - AR01
-
auditors-resignation-company (2013-02-08) - AUD
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-small (2012-10-11) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-small (2011-10-14) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-05-10) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2011-04-06) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-05-17) - CH01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-07-12) - AR01
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2010-07-12) - CH04
-
accounts-with-accounts-type-small (2010-02-17) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
appoint-person-director-company-with-name (2009-12-09) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-12-08) - CH01
-
termination-director-company-with-name (2009-12-07) - TM01
-
legacy (2009-05-12) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-05-09) - 363a
-
legacy (2008-03-28) - 288a
-
accounts-with-accounts-type-small (2008-07-17) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-05-09) - 363a
keyboard_arrow_right 2006
-
resolution (2006-12-11) - RESOLUTIONS
-
legacy (2006-08-16) - 288a
-
legacy (2006-06-01) - 225
-
legacy (2006-06-01) - 287
-
legacy (2006-06-01) - 288b
-
legacy (2006-06-01) - 288a
-
incorporation-company (2006-05-05) - NEWINC