-
ASHWOOD SURGERY LIMITED - C12 Marquis Court, Marquisway Team Valley, Gateshead, Tyne And Wear, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05772643
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C12 Marquis Court
- Marquisway Team Valley
- Gateshead
- Tyne And Wear
- NE11 0RU C12 Marquis Court, Marquisway Team Valley, Gateshead, Tyne And Wear, NE11 0RU UK
Management
- Geschäftsführung
- SINGH, Jagpreet
- SINGH, Reeta Manmeet Kaur, Dr
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.04.2006
- Gelöscht am:
- 2020-07-16
- SIC/NACE
- 86210
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- WILCHAP 445 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2014-12-31
- Letzte Einreichung: 2013-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-04-06
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2017-04-20
- Letzte Einreichung:
-
ASHWOOD SURGERY LIMITED Firmenbeschreibung
- ASHWOOD SURGERY LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05772643. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 06.04.2006 registriert. ASHWOOD SURGERY LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen WILCHAP 445 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "86210" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 06.04.2012.Die Firma kann schriftlich über C12 Marquis Court erreicht werden.
Jetzt sichern ASHWOOD SURGERY LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Ashwood Surgery Limited - C12 Marquis Court, Marquisway Team Valley, Gateshead, Tyne And Wear, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ASHWOOD SURGERY LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-compulsory-return-final-meeting (2020-04-16) - WU15
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-07-16) - GAZ2
-
liquidation-compulsory-winding-up-progress-report (2020-01-31) - WU07
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-compulsory-winding-up-progress-report (2019-02-06) - WU07
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-compulsory-winding-up-progress-report (2018-02-01) - WU07
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-miscellaneous (2017-02-13) - LIQ MISC
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-01-20) - AD01
-
liquidation-compulsory-appointment-liquidator (2016-01-15) - 4.31
-
liquidation-compulsory-winding-up-order (2016-01-08) - COCOMP
keyboard_arrow_right 2015
-
liquidation-voluntary-arrangement-completion (2015-09-28) - 1.4
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
gazette-notice-compulsary (2014-04-08) - GAZ1
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-07-04) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-07) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2014-07-08) - DISS40
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2014-06-10) - DISS16(SOAS)
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-07-24) - MR04
-
liquidation-voluntary-arrangement-meeting-approving-companies-voluntary-arrangement (2014-12-19) - 1.1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-05-23) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2013-05-04) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-02) - AR01
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2013-04-18) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsary (2013-04-02) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2012
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-01-30) - AD01
-
termination-director-company-with-name (2012-01-30) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-08) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-03-28) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-01-04) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-01-30) - AP01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-05-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
termination-secretary-company-with-name (2010-09-30) - TM02
-
termination-director-company-with-name (2010-09-30) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-04-08) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-07-22) - AA
-
move-registers-to-sail-company (2010-04-08) - AD03
-
change-sail-address-company (2010-04-07) - AD02
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-04-07) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-05-14) - AA
-
legacy (2009-04-23) - 363a
-
legacy (2009-04-23) - 288c
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-08-28) - AA
-
legacy (2008-04-09) - 363a
-
legacy (2008-04-09) - 287
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-04-18) - 363a
-
legacy (2007-06-22) - 225
-
legacy (2007-08-31) - 288a
-
legacy (2007-09-12) - 288b
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-09-19) - AA
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-12-13) - 88(2)R
-
resolution (2006-10-25) - RESOLUTIONS
-
certificate-change-of-name-company (2006-10-12) - CERTNM
-
legacy (2006-10-06) - 88(2)R
-
legacy (2006-10-06) - 287
-
legacy (2006-10-06) - 225
-
legacy (2006-10-06) - 288b
-
legacy (2006-10-06) - 288a
-
incorporation-company (2006-04-06) - NEWINC