-
MNA PARTNERSHIP LIMITED - Lumaneri House Blythe Gate, Blythe Valley Park, Solihull, West Midlands, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05697950
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Lumaneri House Blythe Gate
- Blythe Valley Park
- Solihull
- West Midlands
- B90 8AH
- United Kingdom Lumaneri House Blythe Gate, Blythe Valley Park, Solihull, West Midlands, B90 8AH, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- NESSIM, Nils Mathias
- Prokuristen
- JERROM SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 04.02.2006
- Alter der Firma 2006-02-04 18 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Anne Katrine Nessim
- Mr Nils Mathias Nessim
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-09-30
- Letzte Einreichung: 2018-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-02-04
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-02-18
- Letzte Einreichung: 2020-02-04
-
MNA PARTNERSHIP LIMITED Firmenbeschreibung
- MNA PARTNERSHIP LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05697950. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 04.02.2006 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2018 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 04.02.2013.Die Firma kann schriftlich über Lumaneri House Blythe Gate erreicht werden.
Jetzt sichern MNA PARTNERSHIP LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Mna Partnership Limited - Lumaneri House Blythe Gate, Blythe Valley Park, Solihull, West Midlands, Grossbritannien
- 2006-02-04
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MNA PARTNERSHIP LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-02-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-02-18) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-04) - CS01
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2019-06-12) - CH04
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-06-20) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-06-12) - PSC04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-06-12) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-06-04) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-04-11) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-07) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-02-13) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-02-13) - CH01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-15) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-02-15) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-06-20) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-05) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-03-04) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-21) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-05-07) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-06) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-02-25) - CH01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-06) - AA
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name (2012-06-06) - AP04
-
termination-secretary-company-with-name (2012-06-06) - TM02
-
termination-director-company-with-name (2012-06-06) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-02-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
termination-director-company-with-name (2011-11-28) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-11-28) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-06-30) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2011-06-30) - CH03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-05-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-02-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-06-09) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-02-16) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-02-16) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-03-02) - 363a
-
legacy (2009-03-02) - 288c
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-09-25) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-12-15) - AA
-
legacy (2008-02-07) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-07-21) - AA
-
legacy (2007-03-23) - 363a
-
legacy (2007-03-10) - 288c
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-05-19) - 88(2)R
-
legacy (2006-05-19) - 225
-
legacy (2006-03-07) - 288a
-
legacy (2006-02-10) - 288b
-
incorporation-company (2006-02-04) - NEWINC