-
DREWS MANAGEMENT LIMITED - 1, Beasley's Yard, 126 Ahigh Street, Uxbridge, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05679727
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1
- Beasley's Yard
- 126 Ahigh Street
- Uxbridge
- Middlesex
- UB8 1JT 1, Beasley's Yard, 126 Ahigh Street, Uxbridge, Middlesex, UB8 1JT UK
Management
- Geschäftsführung
- ADDERLEY, Glenn Anthony
- Prokuristen
- ADDERLEY, Beverly Dawn
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 18.01.2006
- Alter der Firma 2006-01-18 18 Jahre
- SIC/NACE
- 4521
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2008-11-30
- Letzte Einreichung: 2007-01-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2009-01-17
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2017-01-31
- Letzte Einreichung:
-
DREWS MANAGEMENT LIMITED Firmenbeschreibung
- DREWS MANAGEMENT LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05679727. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 18.01.2006 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "4521" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/01/2007 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 17.01.2009.Die Firma kann schriftlich über 1 erreicht werden.
Jetzt sichern DREWS MANAGEMENT LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Drews Management Limited - 1, Beasley's Yard, 126 Ahigh Street, Uxbridge, Grossbritannien
- 2006-01-18
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DREWS MANAGEMENT LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-11-12) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-05-23) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-10-28) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-05-31) - 4.68
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-04-30) - 4.68
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-10-13) - 4.68
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2017-05-04) - 600
-
liquidation-court-order-miscellaneous (2017-04-07) - LIQ MISC OC
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2017-04-07) - 600
-
liquidation-voluntary-death-liquidator (2017-03-25) - 4.44
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-03-15) - AD01
-
liquidation-court-order-miscellaneous (2017-05-04) - LIQ MISC OC
keyboard_arrow_right 2014
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2014-03-10) - 4.68
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2014-09-09) - 4.68
keyboard_arrow_right 2013
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2013-04-02) - 4.68
keyboard_arrow_right 2012
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2012-03-15) - 4.68
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2012-09-19) - 4.68
keyboard_arrow_right 2011
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2011-11-03) - 4.68
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2011-03-31) - 4.68
keyboard_arrow_right 2010
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2010-09-17) - 4.68
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-09-03) - 287
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2009-09-02) - 4.20
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2009-09-02) - 600
-
resolution (2009-09-02) - RESOLUTIONS
-
legacy (2009-02-02) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-01-17) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-12-01) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-03-22) - 363s
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-01-27) - 287
-
legacy (2006-01-27) - 288b
-
legacy (2006-01-27) - 288a
-
incorporation-company (2006-01-18) - NEWINC