-
QUALITY DESIGN SOLUTIONS LIMITED - C/O Cg&Co Greg's Building, 1 Booth Street, Manchester, M2 4DU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05652844
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Cg&Co Greg's Building
- 1 Booth Street
- Manchester
- M2 4DU C/O Cg&Co Greg's Building, 1 Booth Street, Manchester, M2 4DU UK
Management
- Geschäftsführung
- HARRATT, Michael David
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.12.2005
- Gelöscht am:
- 2020-05-21
- SIC/NACE
- 43290
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Michael David Harratt
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit:
- Letzte Einreichung: 2017-03-31
-
QUALITY DESIGN SOLUTIONS LIMITED Firmenbeschreibung
- QUALITY DESIGN SOLUTIONS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05652844. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 13.12.2005 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43290" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2017 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über C/o Cg&co Greg's Building erreicht werden.
Jetzt sichern QUALITY DESIGN SOLUTIONS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Quality Design Solutions Limited - C/O Cg&Co Greg's Building, 1 Booth Street, Manchester, M2 4DU, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu QUALITY DESIGN SOLUTIONS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-05-21) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2020-02-21) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-02-07) - 600
-
resolution (2019-02-07) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-01-03) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2019-02-07) - LIQ02
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-11-23) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-11-23) - TM02
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-01-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-20) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-21) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-12) - AR01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-10) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-13) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-01-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-12-19) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-01-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-10-07) - AA
-
termination-director-company-with-name (2010-06-15) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-01-21) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2010-01-21) - CH03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-01-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-10-30) - AA
-
legacy (2009-01-12) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-09-22) - 287
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-06-23) - AA
-
legacy (2008-02-05) - 363a
-
legacy (2008-02-05) - 288c
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-01-29) - 363a
-
legacy (2007-03-30) - 288a
-
legacy (2007-03-30) - 225
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-09-11) - AA
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-01-27) - 288c
-
legacy (2006-01-10) - 288a
-
legacy (2006-01-10) - 287
-
legacy (2006-01-10) - 88(2)R
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-12-14) - 288b
-
incorporation-company (2005-12-13) - NEWINC