-
PMG (LECKWITH) LIMITED - 2a, Oak Tree Court, Mulberry Drive Cardiff Gate Business Park, Cardiff, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05632999
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2a
- Oak Tree Court
- Mulberry Drive Cardiff Gate Business Park
- Cardiff
- CF23 8RS 2a, Oak Tree Court, Mulberry Drive Cardiff Gate Business Park, Cardiff, CF23 8RS UK
Management
- Geschäftsführung
- CRANE, Richard John
- GUY, Paul Meyrick
- GUY, Rosemary Ann
- HALL, Michael Robert
- Prokuristen
- GUY, Paul Meyrick
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.11.2005
- Gelöscht am:
- 2021-06-15
- SIC/NACE
- 68209
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- MANDACO 466 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-09-30
- Letzte Einreichung: 2017-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-12-07
- Letzte Einreichung: 2018-11-23
-
PMG (LECKWITH) LIMITED Firmenbeschreibung
- PMG (LECKWITH) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05632999. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 23.11.2005 registriert. PMG (LECKWITH) LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen MANDACO 466 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68209" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2017 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 2A erreicht werden.
Jetzt sichern PMG (LECKWITH) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Pmg (Leckwith) Limited - 2a, Oak Tree Court, Mulberry Drive Cardiff Gate Business Park, Cardiff, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PMG (LECKWITH) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2020-02-12) - DISS40
keyboard_arrow_right 2019
-
gazette-notice-compulsory (2019-02-12) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-04) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2019-12-10) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-03-05) - DISS40
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-15) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-12) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-12-09) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-07) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2017-12-05) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-10-13) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-02-09) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-11) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-01-11) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-01-08) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2016-01-08) - CH03
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-01-05) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-09-15) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-10-13) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2015-10-15) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-12-19) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-11-28) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-25) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2014-10-07) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-12) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-10-22) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2013-09-17) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2012-08-23) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-02) - AR01
-
legacy (2011-11-28) - MG01
-
legacy (2011-11-24) - MG01
-
accounts-with-accounts-type-full (2011-04-05) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-12-01) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2010-06-01) - AA
-
accounts-with-accounts-type-full (2010-03-02) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2010-01-27) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-12-01) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-01-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-04-27) - 88(3)
-
legacy (2009-04-27) - 88(2)
-
resolution (2009-04-27) - RESOLUTIONS
-
legacy (2009-04-16) - 287
-
accounts-with-accounts-type-full (2009-04-02) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-01-08) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-full (2008-04-21) - AA
-
legacy (2008-12-15) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2007-10-30) - AA
-
legacy (2007-09-04) - 225
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-12-28) - 363s
-
legacy (2006-04-19) - 88(2)R
-
legacy (2006-04-19) - 288b
-
legacy (2006-04-19) - 288a
-
resolution (2006-04-19) - RESOLUTIONS
-
certificate-change-of-name-company (2006-02-28) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2005
-
incorporation-company (2005-11-23) - NEWINC