-
TREVALYN PROPERTIES LIMITED - The Mill House, Rossett, Wrexham, LL12 0HL, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05627156
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Mill House
- Rossett
- Wrexham
- LL12 0HL The Mill House, Rossett, Wrexham, LL12 0HL UK
Management
- Geschäftsführung
- BIRKETT EVANS, Christopher James
- BIRKETT EVANS, David Hugh
- Prokuristen
- HUGHES, Catherine
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.11.2005
- Alter der Firma 2005-11-17 18 Jahre
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Christopher James Birkett-Evans
- Christopher James Birkett-Evans
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-08-31
- Letzte Einreichung: 2020-11-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-11-17
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-12-01
- Letzte Einreichung: 2020-11-17
-
TREVALYN PROPERTIES LIMITED Firmenbeschreibung
- TREVALYN PROPERTIES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05627156. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.11.2005 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30.11.2020 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 17.11.2012.Die Firma kann schriftlich über The Mill House erreicht werden.
Jetzt sichern TREVALYN PROPERTIES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Trevalyn Properties Limited - The Mill House, Rossett, Wrexham, LL12 0HL, Grossbritannien
- 2005-11-17
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu TREVALYN PROPERTIES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-08-12) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-12-10) - CS01
-
capital-alter-shares-subdivision (2020-09-05) - SH02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-08-20) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-05-20) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-11) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-04-17) - MR04
keyboard_arrow_right 2017
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-09-07) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-09-12) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-05-22) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-15) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-18) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-04) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-20) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2014-04-01) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name (2014-04-01) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-02-14) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-02-06) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-02-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-small (2011-03-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-12-15) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-12-01) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-small (2010-02-22) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-11-26) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-11-26) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-small (2009-03-04) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-01-10) - 363a
-
legacy (2008-03-29) - 395
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-02-12) - AA
-
legacy (2008-11-18) - 363a
-
legacy (2008-10-09) - 395
keyboard_arrow_right 2007
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-03-02) - AA
-
legacy (2007-01-04) - 395
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-12-07) - 363a
keyboard_arrow_right 2005
-
incorporation-company (2005-11-17) - NEWINC
-
legacy (2005-12-05) - 288a
-
legacy (2005-12-05) - 287
-
legacy (2005-12-05) - 88(2)R
-
legacy (2005-11-29) - 288b