-
ENERGY ALERT LIMITED - Crescent House Hopkinson Way, Portway East Business Park, Andover, SP10 3SF, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05525812
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Crescent House Hopkinson Way
- Portway East Business Park
- Andover
- SP10 3SF
- England Crescent House Hopkinson Way, Portway East Business Park, Andover, SP10 3SF, England UK
Management
- Geschäftsführung
- TAYLOR, Mark Jonathan Lee
- Prokuristen
- TAYLOR, Jennifer Clare
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 02.08.2005
- Alter der Firma 2005-08-02 18 Jahre
- SIC/NACE
- 62012
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Vuepoint Solutions Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-05-31
- Letzte Einreichung: 2019-08-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-06-18
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-07-02
- Letzte Einreichung: 2019-06-18
-
ENERGY ALERT LIMITED Firmenbeschreibung
- ENERGY ALERT LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05525812. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 02.08.2005 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62012" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/08/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 18.06.2012.Die Firma kann schriftlich über Crescent House Hopkinson Way erreicht werden.
Jetzt sichern ENERGY ALERT LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Energy Alert Limited - Crescent House Hopkinson Way, Portway East Business Park, Andover, SP10 3SF, Grossbritannien
- 2005-08-02
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ENERGY ALERT LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-05-31) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-04-06) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-15) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-06) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-06) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-05-09) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-05) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-05-25) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-05-25) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-05-25) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-05-25) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-05-26) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-28) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-10-04) - AD01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-11-04) - MR04
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-15) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2015-05-13) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
capital-allotment-shares (2014-07-14) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-11-22) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-14) - AA
-
memorandum-articles (2013-10-04) - MEM/ARTS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-31) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2013-01-22) - AA
-
resolution (2013-10-04) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-18) - AR01
-
legacy (2012-03-16) - MG01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2011-12-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-09-30) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2011-02-10) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-08-10) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-08-10) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-07-31) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2010-06-23) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2009-05-27) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2008-06-26) - AA
-
legacy (2008-11-10) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2007-09-12) - AA
-
legacy (2007-08-10) - 363a
-
legacy (2007-08-10) - 288c
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-08-02) - 363a
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-09-01) - 288a
-
legacy (2005-09-01) - 288b
-
incorporation-company (2005-08-02) - NEWINC