-
CAMBORNE HOMES LTD. - Freshford House, Redcliffe Way, Bristol, BS1 6NL, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05514761
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Freshford House
- Redcliffe Way
- Bristol
- BS1 6NL
- England Freshford House, Redcliffe Way, Bristol, BS1 6NL, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BARNES, Anthony Paul
- GREENAWAY, Martin
- THORN, Stephen
- Prokuristen
- THORN, Stephen
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.07.2005
- Gelöscht am:
- 2023-03-14
- SIC/NACE
- 43390
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Stephen Thorn
- Mr Anthony Barnes
- Mr Martin Greenaway
- Mr Stephen Thorn
- Mr Anthony Barnes
- Mr Martin Greenaway
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-07-20
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-08-03
- Letzte Einreichung: 2021-07-20
-
CAMBORNE HOMES LTD. Firmenbeschreibung
- CAMBORNE HOMES LTD. ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05514761. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 20.07.2005 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43390" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 20.07.2012.Die Firma kann schriftlich über Freshford House erreicht werden.
Jetzt sichern CAMBORNE HOMES LTD. HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Camborne Homes Ltd. - Freshford House, Redcliffe Way, Bristol, BS1 6NL, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CAMBORNE HOMES LTD. aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-07-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-07-10) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-07-22) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-22) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-07-22) - PSC04
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-06) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-22) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-04-12) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-04-11) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-04-11) - PSC04
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-27) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-20) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-07-11) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-05-08) - AD01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-14) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-08-09) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-27) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-04-08) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-22) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-19) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-05-23) - MR04
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-03) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-14) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-08-14) - CH01
-
liquidation-receiver-abstract-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2014-07-17) - 3.6
-
liquidation-receiver-cease-to-act-receiver (2014-07-17) - RM02
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-07) - AR01
-
liquidation-receiver-appointment-of-receiver (2013-06-27) - RM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-03) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-10-01) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-10-05) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-08-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-10-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-08-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-09-20) - AA
-
legacy (2009-08-24) - 363a
-
legacy (2009-08-24) - 287
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-03-05) - 395
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2008-06-03) - AA
-
legacy (2008-08-11) - 363a
-
legacy (2008-08-11) - 353
keyboard_arrow_right 2007
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2007-08-17) - AA
-
resolution (2007-08-17) - RESOLUTIONS
-
legacy (2007-08-13) - 363a
-
legacy (2007-08-13) - 287
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-10-20) - 225
-
legacy (2006-09-05) - 363s
-
legacy (2006-08-30) - 287
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-12-07) - 395
-
legacy (2005-11-24) - 288c
-
incorporation-company (2005-07-20) - NEWINC